IRTH (9) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIRTH (9) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02845899
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IRTH (9) LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova IRTH (9) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IRTH (9) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FOOD INGREDIENTS FOR INDUSTRY LIMITED09 gen 199509 gen 1995
    REDLYNE LIMITED19 ago 199319 ago 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di IRTH (9) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per IRTH (9) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 11 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ago 2012

    Stato del capitale al 09 ago 2012

    • Capitale: GBP 6,000
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 02 apr 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Charles Wilson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Laura Taylor come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan Prentis come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Laura Taylor come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Chilton come segretario

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 gen 2012 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Charles Wilson come amministratore

    3 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Mr Jonathan Paul Prentis come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mark Chilton come segretario

    3 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 4 Westlinks Alperton Lane Middlesex HA0 1ER in data 18 ott 2010

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Angela Le Vesconte come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Toby King come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Le Vesconte come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Sale come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di IRTH (9) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Segretario
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    158797680001
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    United KingdomBritish155913200001
    CHILTON, Mark
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    Segretario
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    British154975320001
    TISSIER, Anna Katarina
    St Cyrus
    Trout Rise Loudwater
    WD3 4JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    St Cyrus
    Trout Rise Loudwater
    WD3 4JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Swedish63554830001
    WEBB, Bonnie Mae
    38 Longstone Avenue
    NW10 3TU London
    Segretario
    38 Longstone Avenue
    NW10 3TU London
    Irish65783770001
    WEBB, Bonnie Mae
    38 Longstone Avenue
    NW10 3TU London
    Segretario
    38 Longstone Avenue
    NW10 3TU London
    Irish65783770001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BEAUMONT, Graham
    134 Bushey Mill Lane
    WD24 7PB Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    134 Bushey Mill Lane
    WD24 7PB Watford
    Hertfordshire
    British74831420001
    HOFFELNER, Guy Konrad
    66 Clare Road
    SL6 4DQ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    66 Clare Road
    SL6 4DQ Maidenhead
    Berkshire
    British97505830002
    KING, Toby
    61 Mulgrave Road
    W5 1LF London
    Amministratore
    61 Mulgrave Road
    W5 1LF London
    British25979120002
    LE VESCONTE, Angela Marie
    73 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AH Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    73 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AH Rickmansworth
    Hertfordshire
    British12785650001
    LE VESCONTE, Ian John
    73 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AH Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    73 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AH Rickmansworth
    Hertfordshire
    British6354610001
    PRATT, Godfrey John
    43 Barnwell
    Oundle
    PE8 5PS Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    43 Barnwell
    Oundle
    PE8 5PS Peterborough
    Cambridgeshire
    British51766110002
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    United KingdomBritish48949090001
    SALE, Richard Stephen George
    41 Chatsworth Road
    TQ1 3BJ Torquay
    Devon
    Amministratore
    41 Chatsworth Road
    TQ1 3BJ Torquay
    Devon
    United KingdomBritish90491420002
    SIMON, Eva Gabriella
    40 Kenilworth Road
    HA8 8YG Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    40 Kenilworth Road
    HA8 8YG Edgware
    Middlesex
    British36267840002
    TISSIER, Anna Katarina
    St Cyrus
    Trout Rise Loudwater
    WD3 4JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    St Cyrus
    Trout Rise Loudwater
    WD3 4JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Swedish63554830001
    WILSON, Charles
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish123998480001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    IRTH (9) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 set 2006
    Consegnato il 04 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 04 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 29 august 2000 issued by the company
    Creato il 01 nov 2000
    Consegnato il 07 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies now due or hereafter to become due or from time to time accruing due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring, invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 13 august 1996 between confidential invoice discounting limited and TH0 company and any deed amending or replacing the same (all such deeds being hereinafter called the "charged deeds") and all book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 ago 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 lug 1998
    Consegnato il 17 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge supplemental to a guarantee and debenture dated 20TH june 1995 issued by the company and others
    Creato il 07 ago 1997
    Consegnato il 14 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforesaid guarantee and debenture
    Brevi particolari
    Fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of the "charged deeds" (as defined) and all book and other debts amending or replacing the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 ago 1996
    Consegnato il 16 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All debts the subject of an invoice discounting agreement and by way of a floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 16 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 giu 1995
    Consegnato il 11 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or leovic limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0