REFINED MP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREFINED MP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02847780
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REFINED MP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REFINED MP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REFINED MP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MALTHURST PETROLEUM LIMITED21 giu 200021 giu 2000
    GILLINGHAM SERVICE STATION LIMITED22 ott 199822 ott 1998
    HEARTS SERVICES LIMITED25 ago 199325 ago 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di REFINED MP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per REFINED MP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 ago 2019

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of capital redemption reserve 28/08/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Thomas Mckenzie Biggart come amministratore in data 11 mar 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Pinsent Masons Secretarial Limited come segretario in data 07 mar 2019

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di David Hathaway come segretario in data 07 mar 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 feb 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Paul Lane come amministratore in data 31 dic 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr William Bahlsen Bannister come amministratore in data 31 dic 2018

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 02 gen 2019

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Steven John Back come amministratore in data 15 ott 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 ott 2018

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Karen Juanita Dickens come amministratore in data 22 giu 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 01 ott 2017

    7 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 set 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2017 al 31 dic 2017

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di REFINED MP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    BIRD, Edwin Arthur
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Segretario
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British55967160001
    CAMPBELL, James Oliver
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    Segretario
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    British29587680003
    DOWDING, Charles Michael
    1 Oakcroft Drive
    Framingham Earl
    NR14 7JQ Norwich
    Norfolk
    Segretario
    1 Oakcroft Drive
    Framingham Earl
    NR14 7JQ Norwich
    Norfolk
    British13193130001
    FRENCH, Walter
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    Segretario
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    British88005070001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Segretario
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    British117227730001
    KEATING, Roderick Charles
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Segretario
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    British126363230002
    KEIDAN, Michael David Alan
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Segretario
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Other1447490001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BACK, Steven John
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Amministratore
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish205661380001
    CAMPBELL, James Oliver
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    Amministratore
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    United KingdomBritish29587680003
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Amministratore
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish124061360001
    FRENCH, Walter
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    Amministratore
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    EnglandBritish88005070001
    KING, Joseph
    Stratford House
    Stratford Crescent
    NR4 7SF Cringleford
    Norfolk
    Amministratore
    Stratford House
    Stratford Crescent
    NR4 7SF Cringleford
    Norfolk
    British3635770001
    PEACOCK, Graham Frederick
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Amministratore
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish5133310002
    PEACOCK, Graham Frederick
    5 Brook Street
    Little Dunmow
    CM6 3HU Dunmow
    Essex
    Amministratore
    5 Brook Street
    Little Dunmow
    CM6 3HU Dunmow
    Essex
    British5133310001
    PEARS, David Alan
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Amministratore
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish65200910001
    PEARS, Mark Andrew
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Amministratore
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish1447500008
    PEARS, Trevor Steven, Sir
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Amministratore
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish40036010005
    ROBINSON, Melvin Frank
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish146452070001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Amministratore
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    EnglandBritish107002130001
    SHARPE, Steven
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    Amministratore
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    EnglandBritish146452160001
    THOMPSON, Brian Lane
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    British56518620001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Amministratore
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish17957620003
    TOBBELL, Susan Margaret
    The Finch Inn Church Hill
    Finchingfield
    CM7 4NN Essex
    Amministratore
    The Finch Inn Church Hill
    Finchingfield
    CM7 4NN Essex
    United KingdomBritish17957620003
    WPG REGISTRARS LIMITED
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Amministratore
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    106986280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REFINED MP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Refined Estates Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    06 apr 2016
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione04193995
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    REFINED MP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rental assignation
    Creato il 11 gen 2005
    Consegnato il 21 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and refined estates limited to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of all rents payable under the lease entered into between malthurst petroleum limited, malthurst fuels limited and malthurst UK limited dated 17 november 2003, together with such arrears (if any), including (without limitation) all vat (if any) payable on or in respect of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 21 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2004
    Consegnato il 23 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Banking Corporation PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2005 and
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 25 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole subjects k/a milngavie service station, glasgow road, milngavie t/n DMB4074.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 feb 2002
    Consegnato il 26 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as 457 alfreton road nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 lug 2001
    Consegnato il 30 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a little london service station london road spalding lincolnshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mag 2001
    Consegnato il 31 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property being land and buildings on the south side of norwich road gillingham.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee including all such monies as may fall due for payment under any agreements present and future all costs and expenses all sums due for any goods or services supplied by the chargee to the company, any interest payable to the chargee by the company, or sums which become due to the chargee in connection with any loan, and all sums which become due to the chargee in connection with an externally funded loan
    Brevi particolari
    Premises k/a widows cruse filling station gillinham nr beccles norfolk all fixtures and fittings not being personal chattels within the bill of sales act on the premises, all rental income present or future and whether payable now or in the future and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bp Oil UK Limited
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2001
    Consegnato il 30 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 21 june 2001 and
    Creato il 18 mag 2001
    Consegnato il 26 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Milngavie service station, 42 glasgow road, milngavie.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1996
    Consegnato il 28 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a petrol filling station at junction of A143/A146 roads gillingham near beccles norfolk together with all fixtures and fittings at any tim at the property the benefits of all rights licences and the goodwill of the company at the premises.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1996
    Consegnato il 28 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a petrol filling station junction A143/A146 roads gillingham nr. Beccles norfolk together with all fixtures fittings at the premises all rental income at any time all rights and claims against any third parties all goodwill full benefit of all contracts of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mobil Oil Company Limited
    Transazioni
    • 28 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and assignment
    Creato il 19 gen 1995
    Consegnato il 23 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Petrol filling station development site situate at the junction of A143 and A146 gillingham norfolk all and singular the mortgagor's respective rights title and interest in and to each of the development documents and the development. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mobil Oil Company Limited
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 giu 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0