REFINED MP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | REFINED MP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02847780 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REFINED MP LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova REFINED MP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Hertfordshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REFINED MP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MALTHURST PETROLEUM LIMITED | 21 giu 2000 | 21 giu 2000 |
| GILLINGHAM SERVICE STATION LIMITED | 22 ott 1998 | 22 ott 1998 |
| HEARTS SERVICES LIMITED | 25 ago 1993 | 25 ago 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REFINED MP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per REFINED MP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 30 ago 2019
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Thomas Mckenzie Biggart come amministratore in data 11 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Pinsent Masons Secretarial Limited come segretario in data 07 mar 2019 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Hathaway come segretario in data 07 mar 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Simon Paul Lane come amministratore in data 31 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr William Bahlsen Bannister come amministratore in data 31 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 02 gen 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven John Back come amministratore in data 15 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2018 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Karen Juanita Dickens come amministratore in data 22 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 01 ott 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 set 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2017 al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di REFINED MP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 76579530001 | ||||||||||
| BANNISTER, William Bahlsen | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | United Kingdom | British | 252731900001 | |||||||||
| BIGGART, Thomas Mckenzie | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | Scotland | British | 215843640001 | |||||||||
| LANE, Simon Paul | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 252862090001 | |||||||||
| BIRD, Edwin Arthur | Segretario | Hulver Dane O'Coys Road CM23 2JP Bishops Stortford Hertfordshire | British | 55967160001 | ||||||||||
| CAMPBELL, James Oliver | Segretario | 9 Marine Parade Gorleston NR31 6DU Great Yarmouth Norfolk | British | 29587680003 | ||||||||||
| DOWDING, Charles Michael | Segretario | 1 Oakcroft Drive Framingham Earl NR14 7JQ Norwich Norfolk | British | 13193130001 | ||||||||||
| FRENCH, Walter | Segretario | High Farm Bungalow High Farm PE9 3BY Southorpe Lincolnshire | British | 88005070001 | ||||||||||
| HATHAWAY, David | Segretario | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | British | 117227730001 | ||||||||||
| KEATING, Roderick Charles | Segretario | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | British | 126363230002 | ||||||||||
| KEIDAN, Michael David Alan | Segretario | 15 Crooked Usage Finchley N3 3HD London | Other | 1447490001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BACK, Steven John | Amministratore | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 205661380001 | |||||||||
| CAMPBELL, James Oliver | Amministratore | 9 Marine Parade Gorleston NR31 6DU Great Yarmouth Norfolk | United Kingdom | British | 29587680003 | |||||||||
| DICKENS, Karen Juanita, Dr | Amministratore | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 124061360001 | |||||||||
| FRENCH, Walter | Amministratore | High Farm Bungalow High Farm PE9 3BY Southorpe Lincolnshire | England | British | 88005070001 | |||||||||
| KING, Joseph | Amministratore | Stratford House Stratford Crescent NR4 7SF Cringleford Norfolk | British | 3635770001 | ||||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Amministratore | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 5133310002 | |||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Amministratore | 5 Brook Street Little Dunmow CM6 3HU Dunmow Essex | British | 5133310001 | ||||||||||
| PEARS, David Alan | Amministratore | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 65200910001 | |||||||||
| PEARS, Mark Andrew | Amministratore | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 1447500008 | |||||||||
| PEARS, Trevor Steven, Sir | Amministratore | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 40036010005 | |||||||||
| ROBINSON, Melvin Frank | Amministratore | 19 Aylmer Drive HA7 3EJ Stanmore Middlesex | England | British | 146452070001 | |||||||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Amministratore | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | England | British | 107002130001 | |||||||||
| SHARPE, Steven | Amministratore | Kenwood House Kenwood Close NW3 7JL London | England | British | 146452160001 | |||||||||
| THOMPSON, Brian Lane | Amministratore | Rock Hill House Rock Hill OX7 5BA Chipping Norton Oxfordshire | British | 56518620001 | ||||||||||
| TIMBERS, Graham Paul | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 127888240001 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Amministratore | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 17957620003 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Amministratore | The Finch Inn Church Hill Finchingfield CM7 4NN Essex | United Kingdom | British | 17957620003 | |||||||||
| WPG REGISTRARS LIMITED | Amministratore | Ground Floor 30 City Road EC1Y 2AB London | 106986280001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REFINED MP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refined Estates Limited | 06 apr 2016 | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
REFINED MP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rental assignation | Creato il 11 gen 2005 Consegnato il 21 gen 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and refined estates limited to the chargee | |
Brevi particolari The benefit of all rents payable under the lease entered into between malthurst petroleum limited, malthurst fuels limited and malthurst UK limited dated 17 november 2003, together with such arrears (if any), including (without limitation) all vat (if any) payable on or in respect of the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 dic 2004 Consegnato il 23 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2005 and | Creato il 15 dic 2004 Consegnato il 25 gen 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and whole subjects k/a milngavie service station, glasgow road, milngavie t/n DMB4074. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 feb 2002 Consegnato il 26 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property known as 457 alfreton road nottingham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 lug 2001 Consegnato il 30 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold property k/a little london service station london road spalding lincolnshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 mag 2001 Consegnato il 31 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Leasehold property being land and buildings on the south side of norwich road gillingham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 mag 2001 Consegnato il 24 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee including all such monies as may fall due for payment under any agreements present and future all costs and expenses all sums due for any goods or services supplied by the chargee to the company, any interest payable to the chargee by the company, or sums which become due to the chargee in connection with any loan, and all sums which become due to the chargee in connection with an externally funded loan | |
Brevi particolari Premises k/a widows cruse filling station gillinham nr beccles norfolk all fixtures and fittings not being personal chattels within the bill of sales act on the premises, all rental income present or future and whether payable now or in the future and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 mag 2001 Consegnato il 30 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 21 june 2001 and | Creato il 18 mag 2001 Consegnato il 26 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Milngavie service station, 42 glasgow road, milngavie. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 09 feb 1996 Consegnato il 28 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a petrol filling station at junction of A143/A146 roads gillingham near beccles norfolk together with all fixtures and fittings at any tim at the property the benefits of all rights licences and the goodwill of the company at the premises. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 09 feb 1996 Consegnato il 28 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari L/H property k/a petrol filling station junction A143/A146 roads gillingham nr. Beccles norfolk together with all fixtures fittings at the premises all rental income at any time all rights and claims against any third parties all goodwill full benefit of all contracts of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge and assignment | Creato il 19 gen 1995 Consegnato il 23 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Petrol filling station development site situate at the junction of A143 and A146 gillingham norfolk all and singular the mortgagor's respective rights title and interest in and to each of the development documents and the development. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 03 giu 1994 Consegnato il 10 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0