OFFICE ZONE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | OFFICE ZONE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02848787 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OFFICE ZONE LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova OFFICE ZONE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OFFICE ZONE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OSG TRADING LIMITED | 11 ott 2005 | 11 ott 2005 |
| OYEZSTRAKER HOLDINGS LIMITED | 23 ott 1998 | 23 ott 1998 |
| STRAKER (HOLDINGS) LIMITED | 29 set 1993 | 29 set 1993 |
| REFAL 397 LIMITED | 27 ago 1993 | 27 ago 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OFFICE ZONE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per OFFICE ZONE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 12 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 lug 2022 | 10 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 13 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 lug 2021 | 11 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 4 500 Purley Way Croydon Surrey CR0 4NZ a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR in data 27 lug 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 8 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Seconda presentazione per la nomina di Stephen James Horne come amministratore | 6 pagine | RP04AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard John Oates come amministratore in data 17 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Graham Mobbs come amministratore in data 17 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione di Jonathan Paul Moulton come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Officeteam 2 Group Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen James Horne come amministratore in data 04 mar 2019 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Michael Whiteway come amministratore in data 18 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 028487870014, creata il 23 nov 2018 | 60 pagine | MR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 028487870009 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OFFICE ZONE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYNARD, Philippa Anne | Segretario | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | British | 44140850002 | ||||||
| HORNE, Stephen James | Amministratore | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon C/0 Office Team Ltd Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 256352360001 | |||||
| OATES, Richard John | Amministratore | Purley Way CR0 4NZ Croydon Unit 4 C/O Officeteam England | United Kingdom | British | 198603960001 | |||||
| BARHAM, Richard Edgar Charles | Segretario nominato | 58 High Road Loughton Essex | British | 900007310001 | ||||||
| BLANCHARD, Lisa Anne | Segretario | 156 Casewick Road West Norwood SE27 0SZ London | British | 40576530001 | ||||||
| GRAY, David Peter | Segretario | 28a Chaldon Common Road CR3 5DA Caterham Surrey | British | 67707480001 | ||||||
| PARNELL, Julie Caroline | Segretario | 45 Hilldale Road SM1 2JA Cheam Surrey | British | 25488170003 | ||||||
| ALUN-JONES, Derek (John Derek), Sir | Amministratore | The Willows KT24 5JE Effingham Common Surrey | British | 28440590001 | ||||||
| APPLETON, William John | Amministratore | 28 Bedford Avenue Silsoe MK45 4ER Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | 55953830001 | |||||
| CAHILL, Peter Charles | Amministratore | Ilgars Manor Cottages 2 Mosses Lane CM3 8RD South Woodham Ferrers Essex | British | 36596500003 | ||||||
| COX, David | Amministratore | Marloes Comp Lane St Marys Platt TN15 8NR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 70818680001 | |||||
| DONALD, Sidney Milne | Amministratore | 1 Smith Barry Crescent Upper Rissington GL54 2NG Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 64096360001 | |||||
| EADES, Lisa Anne | Amministratore | 4 Moorland Road Maidenbower RH10 7JB Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 40576530004 | |||||
| EWART SMITH, Michael | Amministratore | Unit 4 500 Purley Way Croydon CR0 4NZ Surrey | England | British | 73942450001 | |||||
| EWART SMITH, Michael | Amministratore | The Long Cottage High Street, Old Bursledon SO31 8DL Southampton Hampshire | England | British | 73942450001 | |||||
| GRAY, David Peter | Amministratore | 28a Chaldon Common Road CR3 5DA Caterham Surrey | British | 67707480001 | ||||||
| HEYS, David Michael | Amministratore | Woodside House 597 Wheatley Lane Road BB12 9EP Burnley Lancashire | United Kingdom | British | 71032080003 | |||||
| HICKFORD, John | Amministratore | Gartan House 9a East Ridgeway Cuffley EN6 4AW Potters Bar Hertfordshire | British | 61175600001 | ||||||
| HODGES, Nicholas Robin | Amministratore | 34 Holland Road MK45 2RS Ampthill Bedfordshire | England | British | 48585350003 | |||||
| HODGES, Nicholas Robin | Amministratore | Ramsau 1 Ware Leys Close Marsh Gibbon OX6 0EN Bicester Oxfordshire | British | 48585350002 | ||||||
| LANDSBERG, Kenneth William | Amministratore | 1 Lower Common Road SW15 1BP London | British | 67271850002 | ||||||
| LAWSON, Philip Andrew | Amministratore | Clayton Cottages 65 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | United Kingdom | British | 50604220003 | |||||
| LENNARD, Andrew Dacre | Amministratore | Pheasant Hill House Kemble GL7 6AW Cirencester Gloucestershire | England | British | 68152930001 | |||||
| MCCALLUM, Alexander James | Amministratore | 28 Ouseley Road SW12 8EF London | United Kingdom | British | 93679470001 | |||||
| MOBBS, Andrew Graham | Amministratore | Unit 4 500 Purley Way Croydon CR0 4NZ Surrey | United Kingdom | British | 175045450001 | |||||
| MOORE, Robert James | Amministratore | 19 The Hazels ME8 0SE Gillingham Kent | United Kingdom | British | 77594790001 | |||||
| MORGAN, Richard James | Amministratore | Parkfield 4 Somerville Road B73 6JA Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 15621070003 | |||||
| PITT, Derek Neil | Amministratore | 52 Albany Drive CT6 8PX Herne Bay Kent | British | 14385530005 | ||||||
| PITT, Derek Neil | Amministratore | 160 Shirehall Road DA2 7SN Hawley Kent | British | 14385530003 | ||||||
| RICHARDS, Benjamin William | Amministratore | Highcroft Chilworth Road, Chilworth SO16 7LP Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 157483970001 | |||||
| SANDARS, George Russell | Amministratore delegato nominato | 5 Crescent Road SW20 8EY London | British | 900007300001 | ||||||
| SEAR, Hugh Edward | Amministratore | 1 Lynwood Avenue KT17 4LQ Epsom Surrey | England | English | 47246600001 | |||||
| SMITH, Graham | Amministratore | The Old Vicarage Cottage Atcham SY5 6QE Shrewsbury | British | 69193860001 | ||||||
| STRAKER, Jonathan | Amministratore | 9 Campden Road CR2 7EQ South Croydon Surrey | British | 10770260001 | ||||||
| WHITEWAY, Jeffrey Michael | Amministratore | Unit 4 500 Purley Way Croydon CR0 4NZ Surrey | England | British | 14385570002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OFFICE ZONE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Jonathan Paul Moulton | 06 apr 2016 | Buckingham Street WC2N 6DF London 10 England | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: Guernsey | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Officeteam 2 Group Limited | 06 apr 2016 | Purley Way CR0 4NZ Croydon Unit 4 C/O Officeteam England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
OFFICE ZONE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 23 nov 2018 Consegnato il 29 nov 2018 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 17 lug 2015 Consegnato il 20 lug 2015 | In corso | ||
Breve descrizione Not applicable. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 14 ago 2014 Consegnato il 18 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 lug 2014 Consegnato il 08 ago 2014 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 lug 2014 Consegnato il 08 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 12 giu 2013 Consegnato il 22 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 12 giu 2013 Consegnato il 20 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession | Creato il 20 giu 2007 Consegnato il 22 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The acceding company assigns, with full title guarantee by way of absolute legal assignment the contracts, intellectual property rights, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 17 apr 2003 Consegnato il 23 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 apr 2003 Consegnato il 10 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC acting in its capacity as security agent for itself and those other lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture of even date made between oyezstraker group limited and certain of its subsidiaries (as charging companies) (as defined) | Creato il 30 apr 2001 Consegnato il 15 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money and liabilities at the time by the security agent due , owing or incurred to each beneficiary by (a) the charging company under or pursuant to the senior finance documents; or (b) by each other company (except for sums owed by such company in its capacity as a guarantor for the charging company) under or pursuant to the senior finance documents (all terms defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 01 set 1997 Consegnato il 11 set 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or by any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment of life policies | Creato il 01 set 1997 Consegnato il 11 set 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The policies and all monies including bonuses accrued re : the life policy no. 3522175, life assured hugh sear, sum assured £500,000, cover life, insurer scottish equitable. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 21 mar 1995 Consegnato il 31 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
OFFICE ZONE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0