OFFICE ZONE LIMITED

OFFICE ZONE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOFFICE ZONE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02848787
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OFFICE ZONE LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova OFFICE ZONE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OFFICE ZONE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OSG TRADING LIMITED11 ott 200511 ott 2005
    OYEZSTRAKER HOLDINGS LIMITED23 ott 199823 ott 1998
    STRAKER (HOLDINGS) LIMITED29 set 199329 set 1993
    REFAL 397 LIMITED27 ago 199327 ago 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di OFFICE ZONE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per OFFICE ZONE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 lug 2022

    10 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    13 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 lug 2021

    11 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 4 500 Purley Way Croydon Surrey CR0 4NZ a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR in data 27 lug 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 08 lug 2020

    LRESEX

    Seconda presentazione per la nomina di Stephen James Horne come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    Nomina di Mr Richard John Oates come amministratore in data 17 gen 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Graham Mobbs come amministratore in data 17 gen 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione di Jonathan Paul Moulton come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Notifica di Officeteam 2 Group Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Stephen James Horne come amministratore in data 04 mar 2019

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    04 mar 2020Clarification A second filed AP01 was registered on 04/03/2020.

    Cessazione della carica di Jeffrey Michael Whiteway come amministratore in data 18 gen 2019

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 028487870014, creata il 23 nov 2018

    60 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 028487870009 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OFFICE ZONE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MAYNARD, Philippa Anne
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Segretario
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    British44140850002
    HORNE, Stephen James
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    C/0 Office Team Ltd
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    C/0 Office Team Ltd
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish256352360001
    OATES, Richard John
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    Amministratore
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    United KingdomBritish198603960001
    BARHAM, Richard Edgar Charles
    58 High Road
    Loughton
    Essex
    Segretario nominato
    58 High Road
    Loughton
    Essex
    British900007310001
    BLANCHARD, Lisa Anne
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    Segretario
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    British40576530001
    GRAY, David Peter
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    Segretario
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    British67707480001
    PARNELL, Julie Caroline
    45 Hilldale Road
    SM1 2JA Cheam
    Surrey
    Segretario
    45 Hilldale Road
    SM1 2JA Cheam
    Surrey
    British25488170003
    ALUN-JONES, Derek (John Derek), Sir
    The Willows
    KT24 5JE Effingham Common
    Surrey
    Amministratore
    The Willows
    KT24 5JE Effingham Common
    Surrey
    British28440590001
    APPLETON, William John
    28 Bedford Avenue
    Silsoe
    MK45 4ER Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    28 Bedford Avenue
    Silsoe
    MK45 4ER Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritish55953830001
    CAHILL, Peter Charles
    Ilgars Manor Cottages
    2 Mosses Lane
    CM3 8RD South Woodham Ferrers
    Essex
    Amministratore
    Ilgars Manor Cottages
    2 Mosses Lane
    CM3 8RD South Woodham Ferrers
    Essex
    British36596500003
    COX, David
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish70818680001
    DONALD, Sidney Milne
    1 Smith Barry Crescent
    Upper Rissington
    GL54 2NG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    1 Smith Barry Crescent
    Upper Rissington
    GL54 2NG Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish64096360001
    EADES, Lisa Anne
    4 Moorland Road
    Maidenbower
    RH10 7JB Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    4 Moorland Road
    Maidenbower
    RH10 7JB Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish40576530004
    EWART SMITH, Michael
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    Amministratore
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    EnglandBritish73942450001
    EWART SMITH, Michael
    The Long Cottage
    High Street, Old Bursledon
    SO31 8DL Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    The Long Cottage
    High Street, Old Bursledon
    SO31 8DL Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish73942450001
    GRAY, David Peter
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    Amministratore
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    British67707480001
    HEYS, David Michael
    Woodside House
    597 Wheatley Lane Road
    BB12 9EP Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    Woodside House
    597 Wheatley Lane Road
    BB12 9EP Burnley
    Lancashire
    United KingdomBritish71032080003
    HICKFORD, John
    Gartan House 9a East Ridgeway
    Cuffley
    EN6 4AW Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Gartan House 9a East Ridgeway
    Cuffley
    EN6 4AW Potters Bar
    Hertfordshire
    British61175600001
    HODGES, Nicholas Robin
    34 Holland Road
    MK45 2RS Ampthill
    Bedfordshire
    Amministratore
    34 Holland Road
    MK45 2RS Ampthill
    Bedfordshire
    EnglandBritish48585350003
    HODGES, Nicholas Robin
    Ramsau 1 Ware Leys Close
    Marsh Gibbon
    OX6 0EN Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    Ramsau 1 Ware Leys Close
    Marsh Gibbon
    OX6 0EN Bicester
    Oxfordshire
    British48585350002
    LANDSBERG, Kenneth William
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    Amministratore
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    British67271850002
    LAWSON, Philip Andrew
    Clayton Cottages 65 High Street
    RH9 8DT Godstone
    Surrey
    Amministratore
    Clayton Cottages 65 High Street
    RH9 8DT Godstone
    Surrey
    United KingdomBritish50604220003
    LENNARD, Andrew Dacre
    Pheasant Hill House
    Kemble
    GL7 6AW Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pheasant Hill House
    Kemble
    GL7 6AW Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish68152930001
    MCCALLUM, Alexander James
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    Amministratore
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    United KingdomBritish93679470001
    MOBBS, Andrew Graham
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    Amministratore
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    United KingdomBritish175045450001
    MOORE, Robert James
    19 The Hazels
    ME8 0SE Gillingham
    Kent
    Amministratore
    19 The Hazels
    ME8 0SE Gillingham
    Kent
    United KingdomBritish77594790001
    MORGAN, Richard James
    Parkfield 4 Somerville Road
    B73 6JA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Parkfield 4 Somerville Road
    B73 6JA Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish15621070003
    PITT, Derek Neil
    52 Albany Drive
    CT6 8PX Herne Bay
    Kent
    Amministratore
    52 Albany Drive
    CT6 8PX Herne Bay
    Kent
    British14385530005
    PITT, Derek Neil
    160 Shirehall Road
    DA2 7SN Hawley
    Kent
    Amministratore
    160 Shirehall Road
    DA2 7SN Hawley
    Kent
    British14385530003
    RICHARDS, Benjamin William
    Highcroft
    Chilworth Road, Chilworth
    SO16 7LP Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Highcroft
    Chilworth Road, Chilworth
    SO16 7LP Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish157483970001
    SANDARS, George Russell
    5 Crescent Road
    SW20 8EY London
    Amministratore delegato nominato
    5 Crescent Road
    SW20 8EY London
    British900007300001
    SEAR, Hugh Edward
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    Amministratore
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    EnglandEnglish47246600001
    SMITH, Graham
    The Old Vicarage Cottage
    Atcham
    SY5 6QE Shrewsbury
    Amministratore
    The Old Vicarage Cottage
    Atcham
    SY5 6QE Shrewsbury
    British69193860001
    STRAKER, Jonathan
    9 Campden Road
    CR2 7EQ South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    9 Campden Road
    CR2 7EQ South Croydon
    Surrey
    British10770260001
    WHITEWAY, Jeffrey Michael
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    Amministratore
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    EnglandBritish14385570002

    Chi sono le persone con controllo significativo di OFFICE ZONE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Jonathan Paul Moulton
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    England
    06 apr 2016
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Guernsey
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    06 apr 2016
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03185023
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    OFFICE ZONE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 nov 2018
    Consegnato il 29 nov 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited as General Partner of BECAP12 Gp LP as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transazioni
    • 29 nov 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 lug 2015
    Consegnato il 20 lug 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Receivables Purchaser, Inventory Lender and Property Lender and Lloyds Bank Commercial Finance Limited as Agent (Together "Lloyds")
    Transazioni
    • 20 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 14 ago 2014
    Consegnato il 18 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Becap 12 Gp Limited Acting in Its Capaciy as General Partner of BECAP12 Gp LP, Acting in Its Capacity as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transazioni
    • 18 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 lug 2014
    Consegnato il 08 ago 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 lug 2014
    Consegnato il 08 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2013
    Consegnato il 22 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2013
    Consegnato il 20 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 20 giu 2007
    Consegnato il 22 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The acceding company assigns, with full title guarantee by way of absolute legal assignment the contracts, intellectual property rights, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 22 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 apr 2003
    Consegnato il 23 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 apr 2003
    Consegnato il 10 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC acting in its capacity as security agent for itself and those other lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 10 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture of even date made between oyezstraker group limited and certain of its subsidiaries (as charging companies) (as defined)
    Creato il 30 apr 2001
    Consegnato il 15 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities at the time by the security agent due , owing or incurred to each beneficiary by (a) the charging company under or pursuant to the senior finance documents; or (b) by each other company (except for sums owed by such company in its capacity as a guarantor for the charging company) under or pursuant to the senior finance documents (all terms defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 set 1997
    Consegnato il 11 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or by any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Bank of Scotland Treasury Services PLC
    Transazioni
    • 11 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of life policies
    Creato il 01 set 1997
    Consegnato il 11 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policies and all monies including bonuses accrued re : the life policy no. 3522175, life assured hugh sear, sum assured £500,000, cover life, insurer scottish equitable.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandand Its Successors and Assigns
    Transazioni
    • 11 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 mar 1995
    Consegnato il 31 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OFFICE ZONE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 lug 2020Inizio della liquidazione
    12 dic 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Samuel James Woodward
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0