HYFLEX ROOFING LIMITED

HYFLEX ROOFING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHYFLEX ROOFING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02849114
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HYFLEX ROOFING LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HYFLEX ROOFING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Lexicon
    Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HYFLEX ROOFING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AQUAPROOF LIMITED13 mag 199613 mag 1996
    PALMERS CORROSION CONTROL LIMITED12 nov 199312 nov 1993
    TRUSHELFCO (NO. 1936) LIMITED31 ago 199331 ago 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di HYFLEX ROOFING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HYFLEX ROOFING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HYFLEX ROOFING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    16 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Amasco House 101 Powke Lane Cradley Heath West Midlands B64 5PX a The Lexicon Mount Street Manchester M2 5NT in data 14 ago 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 lug 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di David Patrick Maginnis come amministratore in data 17 lug 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Andrew Brian Williamson come amministratore in data 17 lug 2015

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 set 2014

    Stato del capitale al 24 set 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 set 2013

    Stato del capitale al 23 set 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Tcss Limited il 23 set 2013

    2 pagineCH04

    Cessazione della carica di Burton Macleod come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Tcss Limited il 05 dic 2011

    2 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Tcss Limited il 31 ago 2010

    2 pagineCH04

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HYFLEX ROOFING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TCSS LIMITED
    14 Wells Road
    Stiffkey
    NR23 1AJ Wells-Next-The-Sea
    The Old Townshend Arms
    Norfolk
    England
    Segretario
    14 Wells Road
    Stiffkey
    NR23 1AJ Wells-Next-The-Sea
    The Old Townshend Arms
    Norfolk
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06769299
    135679860001
    WILLIAMSON, Andrew Brian
    Mount Street
    M2 5NT Manchester
    The Lexicon
    Amministratore
    Mount Street
    M2 5NT Manchester
    The Lexicon
    EnglandBritish174885700001
    BOWN, Julian Lemuel
    19 Childsbridge Lane
    Kemsing
    TN15 6TJ Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    19 Childsbridge Lane
    Kemsing
    TN15 6TJ Sevenoaks
    Kent
    British105880001
    KIPPEN, Michael Leslie
    Southfield House
    16 High Street
    BA11 6NZ Rode
    Somerset
    Segretario
    Southfield House
    16 High Street
    BA11 6NZ Rode
    Somerset
    British12230900005
    WATSON, David Twells
    Heathfield
    6 Blakebrook
    DY11 6AP Kidderminster
    Worcestershire
    Segretario
    Heathfield
    6 Blakebrook
    DY11 6AP Kidderminster
    Worcestershire
    British79100950001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Segretario nominato
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    ANTLIFF, Robert Francis
    The Court
    22 Thornholme Road
    SR2 7QG Sunderland
    Amministratore
    The Court
    22 Thornholme Road
    SR2 7QG Sunderland
    British44786400001
    BENTLEY, Paul Arthur
    55 Meadway
    Southgate
    N14 6NJ London
    Amministratore
    55 Meadway
    Southgate
    N14 6NJ London
    EnglandBritish71971440001
    CHANDLER, Christine Anne
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    Amministratore delegato nominato
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    British900007180001
    CLOUGH, Michael Anthony
    Apapa 2a Streetly Crescent
    Four Oaks
    B74 4PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Apapa 2a Streetly Crescent
    Four Oaks
    B74 4PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish58508010001
    KIPPEN, Michael Leslie
    Southfield House
    16 High Street
    BA11 6NZ Rode
    Somerset
    Amministratore
    Southfield House
    16 High Street
    BA11 6NZ Rode
    Somerset
    United KingdomBritish12230900005
    MACLEOD, Burton James
    6 Worcester Place
    Duxbury Park
    PR7 4AP Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    6 Worcester Place
    Duxbury Park
    PR7 4AP Chorley
    Lancashire
    EnglandScottish97987130001
    MAGINNIS, David Patrick
    St Cyres
    10 Upper Brighton Road
    KT6 6JY Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    St Cyres
    10 Upper Brighton Road
    KT6 6JY Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish48592370003
    MCCANN, Edward Bryan
    Cherry Trees
    Uplands
    KT21 2TN Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Cherry Trees
    Uplands
    KT21 2TN Ashtead
    Surrey
    British36914880001
    MCPHERSON, Ian Gordon Sutherland
    Manor House
    GL56 9SB Stretton On Fosse
    Gloucestershire
    Amministratore
    Manor House
    GL56 9SB Stretton On Fosse
    Gloucestershire
    British77768680001
    REEVE, Robert Arthur
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    Amministratore delegato nominato
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    British900007190001
    STOCK, Bryan
    The Coach House
    10 Shepley Road
    B45 8JW Barnt Green
    Worcestershire
    Amministratore
    The Coach House
    10 Shepley Road
    B45 8JW Barnt Green
    Worcestershire
    United KingdomBritish73942950002
    TURNER, Roger Alfred
    62 Derwent Road
    WV6 9ES Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    62 Derwent Road
    WV6 9ES Wolverhampton
    West Midlands
    British64936840001
    TYEKIFF, Richard
    Maryland Horsegate Ride
    SL5 9LS Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Maryland Horsegate Ride
    SL5 9LS Ascot
    Berkshire
    British43180820001
    WATSON, David Twells
    Heathfield
    6 Blakebrook
    DY11 6AP Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Heathfield
    6 Blakebrook
    DY11 6AP Kidderminster
    Worcestershire
    EnglandBritish79100950001

    HYFLEX ROOFING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed relating to a guarantee and debenture dated 19 december 1997
    Creato il 23 mar 1998
    Consegnato il 01 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of variation relating to a guarantee and debenture dated 19TH december 1997 between the charging companies (as defined) and barclays bank PLC (as security trustee)
    Creato il 11 mar 1998
    Consegnato il 14 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 08 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a carpenter street/hill street edinburgh hall south shields tyne & wear t/no TY182217 and TY9886 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    HYFLEX ROOFING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 lug 2015Inizio della liquidazione
    02 set 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Tim Alan Askham
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Praticante
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Conrad Alexander Pearson
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Praticante
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0