PARDEV (LUTON) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PARDEV (LUTON) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02849784 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PARDEV (LUTON) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ONETRADE LIMITED | 01 set 1993 | 01 set 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019 | 14 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 206 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Benjamin Toby Grose come amministratore | 5 pagine | RP04TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Benjamin Toby Grose come amministratore in data 10 apr 2018 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Bruce Michael James come amministratore in data 10 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip John Martin come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip John Martin come segretario in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di British Land Company Secretarial Limited come segretario in data 31 ott 2016 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Charles John Middleton come amministratore in data 13 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 13 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Segretario | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | British | 35118050001 | ||||||||||
| PEARSON, William | Segretario | 12 Hamilton Close SE16 1QJ London | British | 206426340001 | ||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Segretario nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||||||
| BERESFORD, Valentine Tristram | Amministratore | 3 Smith Terrace SW3 4DL London | England | British | 40766290003 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 35118050001 | |||||||||
| MAXTED, Robert David | Amministratore | Vanhurst Thorncombe Street GU5 0ND Bramley Surrey | British | 37177990001 | ||||||||||
| MCGANN, Martin Francis | Amministratore | 10 Westcombe Park Road SE3 7RB Blackheath London | British | 109383240001 | ||||||||||
| MOULD, Harold Raymond | Amministratore | 40 Hasker Street SW3 2LQ London | England | British | 35576350006 | |||||||||
| PEARSON, William | Amministratore | 12 Hamilton Close SE16 1QJ London | England | British | 206426340001 | |||||||||
| PRICE, Humphrey James Montgomery | Amministratore | Deaks Deaks Lane RH17 5JA Cuckfield West Sussex | Uk | British | 14448630001 | |||||||||
| SHEEN, Richard Keith | Amministratore | 53 Elystan Place SW3 3JY London | British | 49750560001 | ||||||||||
| SMITH, Andrew David | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 108214880002 | |||||||||
| STIRLING, Mark Andrew | Amministratore | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | 106882210001 | |||||||||
| VAUGHAN, Patrick Lionel | Amministratore | June Farm Trumpet Hill Road RH2 8QY Reigate Surrey | United Kingdom | British | 73972350001 | |||||||||
| NOROSE LIMITED | Amministratore delegato nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006410001 | |||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Amministratore delegato nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillar Property Group Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
PARDEV (LUTON) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over rent deposit account | Creato il 23 gen 1998 Consegnato il 03 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and schildvink B.V. (together the borrower) to the chargee and their respective successors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner | |
Brevi particolari All sims from time to time standing to the credit of the borrower in the account number 00214912 in the name of the borrower held with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 gen 1998 Consegnato il 03 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and schildvink B.V.(together the borrower) to the chargee and their respective sucessors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner | |
Brevi particolari The f/h property k/a units 400,450 and 475 capability green luton t/n BD164321 with all machinery buildings or other erections any sum paid under any insurance policy any deposit paid of any estate or interest in whole or in part of the property & other assets please refer to form 395 for full details and by way of floating charge all undertaking property and assets of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over acv deposit account | Creato il 23 gen 1998 Consegnato il 03 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The provisions of clause 12.1.17 of the facility agreement dated 21ST december 1993 made between pillar property PLC,pardev (luton) limited and wurttembergische hypothekenbank ag (as agent and trustee for the lender as defined)and their respective successors and assigns and to those deriving title through or under them (together the "lender") as varied by a first variation agreement dated 10TH june 1994 and as amended and restated by a second variation agreement dated 21ST january 1998 and any subsequent variation and amendment to that agreement provides that it will be an event of default under the facility agreement if certain loan-to-loan requirements are not met unless the company repays part of the loan or provides further security or pays money into the account | |
Brevi particolari All sums standing to the credit of the company in an account numbered 00214920 held in the name of the company with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 dic 1993 Consegnato il 06 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a units 1,100,400,450 and 475 capability green luton t/NOSBD145653,BD132562 and BD164321 and all rents receivable and by way of floating charge all undertaking and property of the borrower. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over acv deposit account | Creato il 23 dic 1993 Consegnato il 06 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of clause 12.1.17 of a facility agreement dated 21ST december 1993 | |
Brevi particolari Assignment of all sums from time to time standing to the credit of the company in the acxcount numbered 1528002 at the bank of scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over rent deposit | Creato il 23 dic 1993 Consegnato il 06 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in a facility agreement dated 21ST december 1993 | |
Brevi particolari Assignment by way of security of all sums from time to time standing to the credit of the company in current account number 623461. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0