PARDEV (LUTON) LIMITED

PARDEV (LUTON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARDEV (LUTON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02849784
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARDEV (LUTON) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ONETRADE LIMITED01 set 199301 set 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019

    14 pagineAA

    legacy

    206 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Seconda presentazione per la cessazione di Benjamin Toby Grose come amministratore

    5 pagineRP04TM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Benjamin Toby Grose come amministratore in data 10 apr 2018

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    14 mag 2018Clarification A second filed TM01 was registered on 14/05/2018

    Nomina di Mr Bruce Michael James come amministratore in data 10 apr 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Philip John Martin come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip John Martin come segretario in data 31 ott 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di British Land Company Secretarial Limited come segretario in data 31 ott 2016

    2 pagineAP04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Charles John Middleton come amministratore in data 13 lug 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 13 lug 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 set 2015

    Stato del capitale al 22 set 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Segretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    PEARSON, William
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    Segretario
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    British206426340001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Segretario nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Amministratore
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MAXTED, Robert David
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    Amministratore
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    British37177990001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Amministratore
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    MOULD, Harold Raymond
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Amministratore
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    EnglandBritish35576350006
    PEARSON, William
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    Amministratore
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    EnglandBritish206426340001
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    SHEEN, Richard Keith
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    Amministratore
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    British49750560001
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Amministratore
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Amministratore delegato nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Amministratore delegato nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Pillar Property Group Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    PARDEV (LUTON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over rent deposit account
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 03 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and schildvink B.V. (together the borrower) to the chargee and their respective successors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner
    Brevi particolari
    All sims from time to time standing to the credit of the borrower in the account number 00214912 in the name of the borrower held with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    Transazioni
    • 03 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 03 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and schildvink B.V.(together the borrower) to the chargee and their respective sucessors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner
    Brevi particolari
    The f/h property k/a units 400,450 and 475 capability green luton t/n BD164321 with all machinery buildings or other erections any sum paid under any insurance policy any deposit paid of any estate or interest in whole or in part of the property & other assets please refer to form 395 for full details and by way of floating charge all undertaking property and assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    Transazioni
    • 03 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over acv deposit account
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 03 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The provisions of clause 12.1.17 of the facility agreement dated 21ST december 1993 made between pillar property PLC,pardev (luton) limited and wurttembergische hypothekenbank ag (as agent and trustee for the lender as defined)and their respective successors and assigns and to those deriving title through or under them (together the "lender") as varied by a first variation agreement dated 10TH june 1994 and as amended and restated by a second variation agreement dated 21ST january 1998 and any subsequent variation and amendment to that agreement provides that it will be an event of default under the facility agreement if certain loan-to-loan requirements are not met unless the company repays part of the loan or provides further security or pays money into the account
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit of the company in an account numbered 00214920 held in the name of the company with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    Transazioni
    • 03 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 06 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a units 1,100,400,450 and 475 capability green luton t/NOSBD145653,BD132562 and BD164321 and all rents receivable and by way of floating charge all undertaking and property of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag
    Transazioni
    • 06 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over acv deposit account
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 06 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of clause 12.1.17 of a facility agreement dated 21ST december 1993
    Brevi particolari
    Assignment of all sums from time to time standing to the credit of the company in the acxcount numbered 1528002 at the bank of scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag (As Agent)
    Transazioni
    • 06 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over rent deposit
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 06 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in a facility agreement dated 21ST december 1993
    Brevi particolari
    Assignment by way of security of all sums from time to time standing to the credit of the company in current account number 623461. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag
    Transazioni
    • 06 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0