MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED

MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02850490
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sapphire House
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 22 lug 2022

    • Capitale: GBP 70
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Simon Chidgey come amministratore in data 16 giu 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2021

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Doug Mark Muttitt come amministratore in data 30 apr 2021

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2020 al 30 set 2020

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di David Duffield come amministratore in data 30 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas David Martin Giles come segretario in data 10 lug 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Deborah Hamilton come segretario in data 10 lug 2019

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Jason Kent Greene come amministratore in data 01 lug 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon John Kesterton come amministratore in data 01 lug 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark William Miles come amministratore in data 01 lug 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Petrus Rudolf Maria Vervaat come amministratore in data 01 lug 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAMILTON, Deborah
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    England
    England
    Segretario
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    England
    England
    260771920001
    GREENE, Jason Kent
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    United StatesAmerican189185450001
    MILES, Mark William
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    United StatesAmerican205171710001
    GILES, Nicholas David Martin
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    Segretario
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    206780160001
    HARRIS, Trevor Frank
    Trinity Place
    Mett Ingham
    NR35 1TG Bungay
    Suffolk
    Segretario
    Trinity Place
    Mett Ingham
    NR35 1TG Bungay
    Suffolk
    British7191840001
    JOYCE, Rebecca Katherine
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    183828370001
    LAST, Michael
    24 Arlington Way
    IP24 2DZ Thetford
    Norfolk
    Segretario
    24 Arlington Way
    IP24 2DZ Thetford
    Norfolk
    British93903020001
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Segretario
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    British21883690003
    MUTTITT, Doug Mark
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    British133397700001
    SMITH, Nicholas John
    53 Nicholson Drive
    NR34 9UX Beccles
    Suffolk
    Segretario
    53 Nicholson Drive
    NR34 9UX Beccles
    Suffolk
    British15709160003
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ANDERTON, John Leslie
    7 Pavilion Mews
    St Andrews Park
    NR7 0GN Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    7 Pavilion Mews
    St Andrews Park
    NR7 0GN Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish96454510001
    BRYANT, Mark Gunnar
    Chestnut Farm
    Wood Lane Braunston
    LE15 8QZ Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Chestnut Farm
    Wood Lane Braunston
    LE15 8QZ Oakham
    Leicestershire
    British108779660001
    CHIDGEY, Simon
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish124543450001
    DUFFIELD, David
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish124543570001
    FISHER, Richard Martyn
    295 Wroxham Road
    NR7 8RN Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    295 Wroxham Road
    NR7 8RN Norwich
    Norfolk
    British56616730001
    HARRIS, Trevor Frank
    Trinity Place
    Mett Ingham
    NR35 1TG Bungay
    Suffolk
    Amministratore
    Trinity Place
    Mett Ingham
    NR35 1TG Bungay
    Suffolk
    EnglandBritish7191840001
    KESTERTON, Simon John
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish261794500001
    LAST, Michael
    24 Arlington Way
    IP24 2DZ Thetford
    Norfolk
    Amministratore
    24 Arlington Way
    IP24 2DZ Thetford
    Norfolk
    British93903020001
    MAYNARD, John Edward
    Spexhall Manor
    Wash Lane Spexhall
    IP19 0RE Halesworth
    Suffolk
    Amministratore
    Spexhall Manor
    Wash Lane Spexhall
    IP19 0RE Halesworth
    Suffolk
    EnglandBritish13819510001
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    UkBritish21883690003
    MUTTITT, Doug Mark
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish133397700001
    PENNINGTON, Kevin Joseph
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish105083100001
    SMITH, David William
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish88507540002
    VERVAAT, Petrus Rudolf Maria
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    Northamptonshire
    England
    NetherlandsDutch173885350001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    England
    06 apr 2016
    Crown Way
    NN10 6FB Rushden
    Sapphire House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2016
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04669525
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MAYNARD & HARRIS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental legal charge
    Creato il 15 nov 2007
    Consegnato il 03 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of london road beccles t/no SK160844. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge agreement
    Creato il 10 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to each lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the shares of stock,ownership interests and other securities described in the schedule hereto,all of the certificates and/or instruments representing such shares of stock. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 set 2007
    Consegnato il 20 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)in Its Capacity Assecurity Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 20 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The land k/a primrose dell 83 london road beccles t/n SK85181, 89 london road beccles t/n SK86883 and land to the east of london road beccles t/n SK110196 (forfurther details of the property charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 set 1996
    Consegnato il 13 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1996
    Consegnato il 03 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    0.2 acres of land at london road industrial estate beccles suffolk with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1996
    Consegnato il 03 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit block 2 london road industrial estate beccles suffolk with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0