OLD COMPANY 20 LIMITED

OLD COMPANY 20 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOLD COMPANY 20 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02854310
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OLD COMPANY 20 LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
    • Riassicurazione non vita (65202) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hampden House
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MS AMLIN LIMITED03 dic 201903 dic 2019
    MS AMLIN PLC29 feb 201629 feb 2016
    AMLIN PLC25 set 199825 set 1998
    ANGERSTEIN UNDERWRITING TRUST PLC.30 set 199330 set 1993
    HACKPLIMCO (NO.TEN) PUBLIC LIMITED COMPANY17 set 199317 set 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Francis William Johnston come amministratore in data 01 ott 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 ott 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street London EC3V 4AG United Kingdom a Hampden House Great Hampden Great Missenden HP16 9rd in data 21 dic 2020

    1 pagineAD01

    Notifica di Hampden Group Management Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2020

    2 paginePSC02

    Cessazione della carica di Satoshi Watabe come amministratore in data 01 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Shinichi Imayoshi come amministratore in data 01 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione di Ms&Ad Insurance Group Holdings, Inc. come persona con controllo significativo il 01 ott 2020

    1 paginePSC07

    Cessazione della carica di Frederick Christopher Foreman come segretario in data 01 ott 2020

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Frederick Christopher Foreman come amministratore in data 01 ott 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Hampden Legal Plc come segretario in data 01 ott 2020

    2 pagineAP04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name14 set 2020

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 set 2020

    RES15

    Soddisfazione dell'onere 27 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    38 pagineAA

    Cessazione della carica di James Le Tall Illingworth come amministratore in data 17 feb 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Charles Waldegrave Beale come amministratore in data 01 gen 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Frederick Christopher Foreman come amministratore in data 01 gen 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Shinichi Imayoshi come amministratore in data 01 gen 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Satoshi Watabe come amministratore in data 01 gen 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tadashi Yamada come amministratore in data 29 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Oliver Lars Edwin Peterken come amministratore in data 29 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Shinichi Imayoshi come amministratore in data 29 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip James Calnan come amministratore in data 29 nov 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAMPDEN LEGAL PLC
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Segretario
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione01988859
    56301100002
    JOHNSTON, Francis William
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Amministratore
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    EnglandBritish252387340001
    CASEMENT, David Alexander
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Segretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    208714580001
    FELTON, Esther
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Segretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    250659420001
    FENWICK, Graham Peter
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Segretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    250656700001
    FOREMAN, Frederick Christopher
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Segretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    257855140001
    PENDER, Charles Christopher Tresilian
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Segretario
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    British63509920002
    PURVIS, Martin Terence Alan
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helens
    England
    Segretario
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helens
    England
    British160188970001
    STEVENS, Mark Philip David
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Segretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    British165810220001
    WALSH, Gerard Charles Paul Radford
    Stones
    Fittleworth Road Wisborough Green
    RH14 0HB Billingshurst
    West Sussex
    Segretario
    Stones
    Fittleworth Road Wisborough Green
    RH14 0HB Billingshurst
    West Sussex
    British49851890001
    FRIENDS IVORY & SIME PLC
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Segretario
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    597700003
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ADAM, Robin John Leaver
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish185607020001
    ALBERS, Martin
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    SwitzerlandSwiss238103990001
    ANDREWS, John Michael Geoffrey
    80 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    Amministratore
    80 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    United KingdomBritish4263690001
    ARNOLD, Simon Rory
    Bulls Barn
    Ditchling Common, Ditchling
    BN6 8TN Hassocks
    West Sussex
    Amministratore
    Bulls Barn
    Ditchling Common, Ditchling
    BN6 8TN Hassocks
    West Sussex
    British66604710003
    BEALE, Simon Charles Waldegrave
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish73686760003
    BOSSE, Christine
    Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's 1
    Amministratore
    Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's 1
    DenmarkDanish134998700001
    BUCHANAN, Nigel James Cubitt
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Amministratore
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    EnglandBritish43563090001
    CALNAN, Philip James
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish204253780001
    CARPENTER, Brian Douglas
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Amministratore
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    EnglandBritish21299200002
    CHAKRAVERTY, Julie
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish114083240001
    COLLINS, Alan Stanley, Sir
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's
    England
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's
    England
    EnglandBritish164621880001
    DAVEY, Richard Harding
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish109835600002
    FEINSTEIN, Martin Douglas
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    UsaAmerican126648610001
    FOREMAN, Frederick Christopher
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish265658530001
    FUKUHARA, Kenichi
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomJapanese174804060001
    HARRIES, David Nicholas
    39 Holden Way
    RM14 1BT Upminster
    Essex
    Amministratore
    39 Holden Way
    RM14 1BT Upminster
    Essex
    EnglandEnglish11628540002
    HEXTALL, Richard Anthony
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish283405430001
    HOBROW, Anthony Gordon Piers
    Park Farm Barn Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Park Farm Barn Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    British6515440002
    HOLT, Anthony Wareham
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Amministratore
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    British29462730003
    HOLT, Anthony Wareham
    Great Orchard
    Bignor
    RH20 1PQ Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Great Orchard
    Bignor
    RH20 1PQ Pulborough
    West Sussex
    British29462730003
    ILLINGWORTH, James Le Tall
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Amministratore
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish51360900002
    ILLINGWORTH, James Le Tall
    9 Ennismore Avenue
    Chiswick
    W4 1SE London
    Amministratore
    9 Ennismore Avenue
    Chiswick
    W4 1SE London
    British51360900001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    01 ott 2020
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01085256
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Ms&Ad Insurance Group Holdings, Inc.
    Shinkawa 2-Chome
    Chuo-Ku
    1040033 Tokyo
    27-2
    Japan
    06 apr 2016
    Shinkawa 2-Chome
    Chuo-Ku
    1040033 Tokyo
    27-2
    Japan
    Forma giuridicaPublic Company
    Paese di registrazioneJapan
    Autorità legaleJapan
    Luogo di registrazioneJapan
    Numero di registrazione010001116542
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    OLD COMPANY 20 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over account
    Creato il 02 ago 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies up to a maximum amount of £28,000,000 due or to become due from amlin corporate services limited to the scheme on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge the account. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lsf Pensions Management Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 ago 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2005
    Consegnato il 30 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 30 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 02 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 02 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 11 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title and interest in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, the uncalled capital, the investments, all monetary claims and all related rights.right title and interest in and to the proceeds of any insurance policy and all related rights. By way of first floating charge the whole of the companys undertaking and assets present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC, as Agent and Trustee for the Finance Parties Under the Facility Agreement
    Transazioni
    • 11 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A debenture
    Creato il 01 gen 2003
    Consegnato il 02 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The right title and interest from time to time in and to the real property. The tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, uncalled capital, the investments, the shares, all dividends interest and other monies, all monetary claims.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Trustee for the Finance Parties Under the Facility Agreement)
    Transazioni
    • 02 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 lug 2001
    Consegnato il 14 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2000
    Consegnato il 28 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (all as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC ("Trustee")
    Transazioni
    • 28 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of further charge
    Creato il 01 gen 1998
    Consegnato il 22 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a deed of covenant of even date and this charge
    Brevi particolari
    Further fixed charge all right title and interest in the "mortgaged securities" and the "charged cash" as defined on the 395 and further floating charge the whole of the rights and. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society of Lloyd's
    Transazioni
    • 22 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee amending a fixed and floating charge dated 30TH november 1993 as defined in this deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest in the mortgaged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The "Society"
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations of aut (no 10) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations of aut (no 9) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations of aut (no 8) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All future profits and moneys of the company...........see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations of aut (no 7) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations of aut (no.6) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations aut (no 5) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All moneys or other property after the date of trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations of aut (no 4) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the underwriting obligations aut (no 3) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brevi particolari
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0