HARRISON COWLEY 222 LIMITED

HARRISON COWLEY 222 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARRISON COWLEY 222 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02858045
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HARRISON COWLEY 222 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor, Holborn Gate
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAWLAW 222 LIMITED01 apr 199801 apr 1998
    HARRISON COWLEY LTD05 gen 199605 gen 1996
    HALL HARRISON COWLEY LIMITED18 feb 199418 feb 1994
    MAWLAW 222 LIMITED29 set 199329 set 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per HARRISON COWLEY 222 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 nov 2018

    • Capitale: GBP 0.01
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 15/11/2018
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY a 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN in data 04 ago 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Neil Garth Jones come amministratore in data 01 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rebecca Adele Horne come amministratore in data 01 lug 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 set 2015

    Stato del capitale al 14 set 2015

    • Capitale: GBP 193.6
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mrs Rebecca Adele Horne come amministratore in data 01 lug 2015

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD a 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY in data 28 giu 2015

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Alison Jane Clarke come amministratore in data 14 giu 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Alison Jane Clarke come amministratore in data 31 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sally-Ann Patricia Withey come amministratore in data 31 dic 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Neil Garth
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Amministratore
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    EnglandBritishFinance Director204774750001
    MORROW, Martin
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Amministratore
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant167225950001
    CULVER EVANS, Philip Frederick
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    Segretario
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    BritishAccountant93870000001
    GLYNN, Michael Richard
    19a British Grove
    W4 2NL London
    Segretario
    19a British Grove
    W4 2NL London
    BritishCompany Director50624740001
    HATFIELD, Adam George Roland
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    Segretario
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary84503340001
    LAWSON, David Sydney
    15 Montford Mews
    Hazlemere
    HP15 7FR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    15 Montford Mews
    Hazlemere
    HP15 7FR High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant69676920003
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Segretario
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    MAXWELL, Herbert Henry
    76 Iffley Road
    W6 0PF London
    Segretario
    76 Iffley Road
    W6 0PF London
    BritishChartered Accountant49703000001
    WESTOBY, Nicola
    23 Anglesea Place
    Clifton
    BS8 2UN Bristol
    Segretario
    23 Anglesea Place
    Clifton
    BS8 2UN Bristol
    BritishAccountant49141710002
    WHITE, Jeremy Mark
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    Segretario
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    BritishChartered Accountant51297980001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Segretario
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    ADAMS, Colin Raymond
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Amministratore
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishFinance Director39245820011
    BROADHEAD, Tymon Piers
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Amministratore
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritishAccountant105342600002
    CLARKE, Alison Jane
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Amministratore
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    United KingdomBritishCompany Director93418210001
    CULVER EVANS, Philip Frederick
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    Amministratore
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director93870000001
    DAWSON, Mary Louise
    5 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    Amministratore
    5 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    United KingdomBritishAccountant113405020001
    FADIL, Susan Carol
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    British900006600001
    FOWLES, John Anthony David
    Mulberry Court
    Barnsley
    GL7 5EJ Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Mulberry Court
    Barnsley
    GL7 5EJ Cirencester
    Gloucestershire
    BritishAdvertising Executive30663720001
    GLYNN, Michael Richard
    19a British Grove
    W4 2NL London
    Amministratore
    19a British Grove
    W4 2NL London
    EnglandBritishCompany Director50624740001
    HATFIELD, Adam George Roland
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant84503340001
    HEAL, David Michael
    43 Westbourne Road
    PR8 2HY Southport
    Merseyside
    Amministratore
    43 Westbourne Road
    PR8 2HY Southport
    Merseyside
    BritishPublic Relations Consultant50843530001
    HORNE, Rebecca Adele
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    Amministratore
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    United KingdomBritishAccountant188956200001
    KEIL, Charles George
    Illyria
    536 Streetbrook Road
    B91 1RD Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Illyria
    536 Streetbrook Road
    B91 1RD Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director33436380001
    LAWSON, John Edward
    Park Cottage
    Hurley
    SL6 5LN Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Park Cottage
    Hurley
    SL6 5LN Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishAdvertising & Pr Agency Manage26674380001
    LONG, Garry
    Malt House Farm Lower Road
    Stoke Mandeville
    HP22 5UX Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Malt House Farm Lower Road
    Stoke Mandeville
    HP22 5UX Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishManagement Consultant11697860001
    MAXWELL, Herbert Henry
    76 Iffley Road
    W6 0PF London
    Amministratore
    76 Iffley Road
    W6 0PF London
    BritishFinancial Director49703000001
    OLDALE, John Keith
    Little Coopers Coopers Hill
    Eversley
    RG27 0QA Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Little Coopers Coopers Hill
    Eversley
    RG27 0QA Basingstoke
    Hampshire
    BritishSolicitor2038950001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Amministratore
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishFinance Director10691510002
    SIMMS, Geoffrey Mcfarlane
    The Croft Birthwhistle Lane
    Nunney Road
    BA11 4LA Frome
    Somerset
    Amministratore
    The Croft Birthwhistle Lane
    Nunney Road
    BA11 4LA Frome
    Somerset
    BritishPublic Relations Consultant90850780001
    WHITE, Jeremy Mark
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    Amministratore
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    BritishChartered Accountant51297980001
    WITHEY, Sally-Ann Patricia
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Amministratore
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritishChief Operating Officer109428260052

    Chi sono le persone con controllo significativo di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Grayling Communications Limited
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    06 apr 2016
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006 (As Amended)
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione3140273
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    HARRISON COWLEY 222 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an onmibus letter of set-off dated 13 july 2001
    Creato il 18 mag 2004
    Consegnato il 21 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any accounts of the companies or any of them.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 ago 1997
    Consegnato il 05 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Brevi particolari
    The sum of £6,970 paid by the company to the chargee and held in a specifically designated deposit account with barclays bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Starway Property Investments Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 gen 1996
    Consegnato il 06 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Wales PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 04 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited and Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0