HARRISON COWLEY 222 LIMITED
Panoramica
Nome della società | HARRISON COWLEY 222 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02858045 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HARRISON COWLEY 222 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MAWLAW 222 LIMITED | 01 apr 1998 | 01 apr 1998 |
HARRISON COWLEY LTD | 05 gen 1996 | 05 gen 1996 |
HALL HARRISON COWLEY LIMITED | 18 feb 1994 | 18 feb 1994 |
MAWLAW 222 LIMITED | 29 set 1993 | 29 set 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per HARRISON COWLEY 222 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 26 nov 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY a 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN in data 04 ago 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Neil Garth Jones come amministratore in data 01 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Rebecca Adele Horne come amministratore in data 01 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Rebecca Adele Horne come amministratore in data 01 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD a 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY in data 28 giu 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Alison Jane Clarke come amministratore in data 14 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Ms Alison Jane Clarke come amministratore in data 31 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Sally-Ann Patricia Withey come amministratore in data 31 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Neil Garth | Amministratore | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | England | British | Finance Director | 204774750001 | ||||
MORROW, Martin | Amministratore | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 167225950001 | ||||
CULVER EVANS, Philip Frederick | Segretario | Bradfield Cottage Bradfield Willand EX15 2RA Cullompton Devon | British | Accountant | 93870000001 | |||||
GLYNN, Michael Richard | Segretario | 19a British Grove W4 2NL London | British | Company Director | 50624740001 | |||||
HATFIELD, Adam George Roland | Segretario | Old Berkeley Cottage Common Road WD3 5LW Chorleywood Hertfordshire | British | Company Secretary | 84503340001 | |||||
LAWSON, David Sydney | Segretario | 15 Montford Mews Hazlemere HP15 7FR High Wycombe Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 69676920003 | |||||
LEES, Jennifer Kathryn | Segretario | 15-17 Huntsworth Mews NW1 6DD London | British | 24587010002 | ||||||
MAXWELL, Herbert Henry | Segretario | 76 Iffley Road W6 0PF London | British | Chartered Accountant | 49703000001 | |||||
WESTOBY, Nicola | Segretario | 23 Anglesea Place Clifton BS8 2UN Bristol | British | Accountant | 49141710002 | |||||
WHITE, Jeremy Mark | Segretario | 14 Parkway Ratton BN20 9DX Eastbourne Sussex | British | Chartered Accountant | 51297980001 | |||||
MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Segretario | Black Friars Lane EC4V 6HD London 20 | 39182980001 | |||||||
ADAMS, Colin Raymond | Amministratore | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | England | British | Finance Director | 39245820011 | ||||
BROADHEAD, Tymon Piers | Amministratore | Huntsworth Mews NW1 6DD London 15-17 | England | British | Accountant | 105342600002 | ||||
CLARKE, Alison Jane | Amministratore | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | United Kingdom | British | Company Director | 93418210001 | ||||
CULVER EVANS, Philip Frederick | Amministratore | Bradfield Cottage Bradfield Willand EX15 2RA Cullompton Devon | United Kingdom | British | Finance Director | 93870000001 | ||||
DAWSON, Mary Louise | Amministratore | 5 Franconia Road Clapham SW4 9NB London | United Kingdom | British | Accountant | 113405020001 | ||||
FADIL, Susan Carol | Amministratore delegato nominato | Shemer Ash Road Hawley DA2 7SB Dartford Kent | British | 900006600001 | ||||||
FOWLES, John Anthony David | Amministratore | Mulberry Court Barnsley GL7 5EJ Cirencester Gloucestershire | British | Advertising Executive | 30663720001 | |||||
GLYNN, Michael Richard | Amministratore | 19a British Grove W4 2NL London | England | British | Company Director | 50624740001 | ||||
HATFIELD, Adam George Roland | Amministratore | Old Berkeley Cottage Common Road WD3 5LW Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 84503340001 | ||||
HEAL, David Michael | Amministratore | 43 Westbourne Road PR8 2HY Southport Merseyside | British | Public Relations Consultant | 50843530001 | |||||
HORNE, Rebecca Adele | Amministratore | London Wall Buildings EC2M 5SY London 3 England | United Kingdom | British | Accountant | 188956200001 | ||||
KEIL, Charles George | Amministratore | Illyria 536 Streetbrook Road B91 1RD Solihull West Midlands | British | Company Director | 33436380001 | |||||
LAWSON, John Edward | Amministratore | Park Cottage Hurley SL6 5LN Maidenhead Berkshire | England | British | Advertising & Pr Agency Manage | 26674380001 | ||||
LONG, Garry | Amministratore | Malt House Farm Lower Road Stoke Mandeville HP22 5UX Aylesbury Buckinghamshire | British | Management Consultant | 11697860001 | |||||
MAXWELL, Herbert Henry | Amministratore | 76 Iffley Road W6 0PF London | British | Financial Director | 49703000001 | |||||
OLDALE, John Keith | Amministratore | Little Coopers Coopers Hill Eversley RG27 0QA Basingstoke Hampshire | British | Solicitor | 2038950001 | |||||
SELMAN, Roger Malcolm | Amministratore | 5 Vineries Bank Milespit Hill Mill Hill NW7 2RP London | United Kingdom | British | Finance Director | 10691510002 | ||||
SIMMS, Geoffrey Mcfarlane | Amministratore | The Croft Birthwhistle Lane Nunney Road BA11 4LA Frome Somerset | British | Public Relations Consultant | 90850780001 | |||||
WHITE, Jeremy Mark | Amministratore | 14 Parkway Ratton BN20 9DX Eastbourne Sussex | British | Chartered Accountant | 51297980001 | |||||
WITHEY, Sally-Ann Patricia | Amministratore | Huntsworth Mews NW1 6DD London 15-17 | England | British | Chief Operating Officer | 109428260052 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HARRISON COWLEY 222 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grayling Communications Limited | 06 apr 2016 | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate, England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
HARRISON COWLEY 222 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of admission to an onmibus letter of set-off dated 13 july 2001 | Creato il 18 mag 2004 Consegnato il 21 mag 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any accounts of the companies or any of them. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 01 ago 1997 Consegnato il 05 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Brevi particolari The sum of £6,970 paid by the company to the chargee and held in a specifically designated deposit account with barclays bank PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 05 gen 1996 Consegnato il 06 gen 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 31 gen 1994 Consegnato il 04 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0