SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED

SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02858371
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    PO BOX 36
    2 New Star Road
    LE4 9JQ Leicester
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LAPISGREEN LIMITED30 set 199330 set 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ott 2012

    Stato del capitale al 01 ott 2012

    • Capitale: GBP 500,000
    SH01

    Cessazione della carica di Kathryn Ethel Sena come segretario in data 15 ago 2012

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di John Joseph Molinelli come amministratore in data 01 lug 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLEY, David Bruce
    Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    65
    West Midlands
    England
    Segretario
    Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    65
    West Midlands
    England
    British135136470002
    COLEY, David Bruce
    Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    65
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    65
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish135136470002
    ANDREWS, John Beresford
    Lynbere Apple Grove Ashfield Road
    Wetherden
    IP14 3LY Stowmarket
    Suffolk
    Segretario
    Lynbere Apple Grove Ashfield Road
    Wetherden
    IP14 3LY Stowmarket
    Suffolk
    British8066550002
    BUCKLEY, Cathryn Ann
    38 Calder Close
    WR9 8DU Droitwich
    Worcestershire
    Segretario
    38 Calder Close
    WR9 8DU Droitwich
    Worcestershire
    British64030380001
    CHILTON, Derek Geoffrey
    Burton House
    10 Melton Road, Burton Lazars
    LE14 2UR Melton Mowbray
    Leicestershire
    Segretario
    Burton House
    10 Melton Road, Burton Lazars
    LE14 2UR Melton Mowbray
    Leicestershire
    British65999450005
    HOWARD, Robert Damian
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    Segretario
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    British43509060001
    SENA, Kathryn Ethel
    24 Henredon Drive
    Phoenixville
    Pa 19460
    Usa
    Segretario
    24 Henredon Drive
    Phoenixville
    Pa 19460
    Usa
    Other98604200002
    WESTMORELAND, Dean Adrian
    The Three Horseshoes
    Main Street
    DE74 2RB Hemington
    Derbyshire
    Segretario
    The Three Horseshoes
    Main Street
    DE74 2RB Hemington
    Derbyshire
    British67026350001
    HOWARD, Robert Damian
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    British43509060001
    MOLINELLI, John Joseph
    1106 Daniel Davis Lane
    19382 West Chester
    Pennsylvania 19382
    Usa
    Amministratore
    1106 Daniel Davis Lane
    19382 West Chester
    Pennsylvania 19382
    Usa
    UsaAmerican44553410001
    RICKETTS, Andrew Frederick
    St Andrews Lodge Church Lane
    West Deeping
    PE6 9HU Peterborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    St Andrews Lodge Church Lane
    West Deeping
    PE6 9HU Peterborough
    Lincolnshire
    British8066560004
    TEE, Henry Leonard
    Vineyard Manor High Street
    SG10 6BS Much Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Vineyard Manor High Street
    SG10 6BS Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10786060002
    TEMPEST, Philip Anthony
    Field House
    Kirton
    IP10 0PZ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Field House
    Kirton
    IP10 0PZ Ipswich
    Suffolk
    British36898820002
    THOMPSON, John Robert
    4 Osmund Close
    Worth
    RH10 7RG Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    4 Osmund Close
    Worth
    RH10 7RG Crawley
    West Sussex
    British78454440001
    VAISEY, Alfred John
    Royse House 4 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Royse House 4 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    British22038910002
    ZAPICO, David Anthony
    204 Excalibur Drive
    19073 Newtown Square
    Pennsylvania
    United States Of America
    Amministratore
    204 Excalibur Drive
    19073 Newtown Square
    Pennsylvania
    United States Of America
    American94136600002

    SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over goodwill
    Creato il 24 nov 1993
    Consegnato il 07 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or solarton instruments limited to the chargee under the terms of the facilities agreement and/or the swap agreements (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustees
    Transazioni
    • 07 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of patents
    Creato il 24 nov 1993
    Consegnato il 07 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or solarton instruments (1994) limited to the chargee under the terms of the facilities agreement and/or the swap agreements (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustees
    Transazioni
    • 07 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 nov 1993
    Consegnato il 07 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facility agreement and/or the swap agreements (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transazioni
    • 07 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0