RST SUPPORT SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RST SUPPORT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02861401 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RST SUPPORT SERVICES LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova RST SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1-3 Manor Road ME4 6AE Chatham Kent |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RST SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RESPONSE SERVICES (UK) LIMITED | 08 feb 2005 | 08 feb 2005 |
| THE WASHROOM COMPANY LIMITED | 12 ott 1993 | 12 ott 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RST SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Quali sono le ultime deposizioni per RST SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 028614010006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10a First Floor Station Road Hayes Middlesex UB3 4DA England a 1-3 Manor Road Chatham Kent ME4 6AE in data 21 ago 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gallagher & Brocklehurst come segretario in data 08 mag 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 4 Plantagenet Road New Barnet Hertfordshire EN5 5JQ a 10a First Floor Station Road Hayes Middlesex UB3 4DA in data 01 giu 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 028614010006, creata il 09 set 2015 | 16 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Bilancio modificato di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 4 pagine | AAMD | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 028614010005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 028614010005 | 17 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed response services (uk) LIMITED\certificate issued on 18/06/13 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Brian David Hilton il 08 nov 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RST SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILTON, Brian David | Amministratore | Manor Road ME4 6AE Chatham 1-3 Kent | United Kingdom | British | 90792560006 | |||||||||||
| BROCKLEHURST, Simon Enfield | Segretario | Northill Grange Northill SG18 9AQ Biggleswade Bedfordshire | British | 134644340001 | ||||||||||||
| MILBURN, Paula Helen | Segretario | 40 Southwood Park Southwood Lawn Road Highgate N6 5SG London | British | 36405440003 | ||||||||||||
| GALLAGHER & BROCKLEHURST | Segretario | Plantagenet Road EN5 5JQ New Barnet 4 Hertfordshire United Kingdom |
| 74782640001 | ||||||||||||
| DAVIS, Kevin Michael Charles | Amministratore | 19 Swan View RH20 2BF Pulborough West Sussex | British | 60828370001 | ||||||||||||
| GALLAGHER, John Edward Masterson | Amministratore | 33 Cholmeley Lodge Highgate Village N6 5EN London | British | 6714810001 | ||||||||||||
| PERKINS, Marion Hilda | Amministratore | 4 Hillside Croft Elmdon B92 9DL Solihull West Midlands | British | 102555120001 | ||||||||||||
| SEARLE, William Arnold | Amministratore | 44 Wissage Road WS13 6SW Litchfield Staffordshire | British | 102955440001 | ||||||||||||
| STEVENSON, Michael James | Amministratore | 28 Lanchester Road N6 4TA London | British | 10277540001 |
RST SUPPORT SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 09 set 2015 Consegnato il 10 set 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione I) all freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including any land and buildings specified in section 3 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all plant and machinery from time to time in or on any such land or buildings; and. Ii) all intellectual property now owned or at any time hereafter to be owned by the company.”. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 lug 2013 Consegnato il 30 lug 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione I) all freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including any land and buildings specified in section 3 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all plant and machinery from time to time in or on any such land or buildings; and. Ii) all intellectual property now owned or at any time hereafter to be owned by the company.”. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over book debts | Creato il 15 lug 2004 Consegnato il 20 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari By way of fixed charge all book debts and other debts and by way of floating charge all the book debts and other debts of the company which are not charged hereunder by way of fixed charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 set 2002 Consegnato il 11 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All assets of the company as defined in the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 18 lug 2001 Consegnato il 26 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the financing agreement | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 25 ago 1994 Consegnato il 02 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0