FIBRENET SOLUTIONS LIMITED

FIBRENET SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIBRENET SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02863897
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIBRENET SOLUTIONS LIMITED?

    • (4531) /

    Dove si trova FIBRENET SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    DAVID RUBEN AND PARTNERS LLP
    Pearl Assurance House 319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FIBRENET SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BUNRATTY MANAGEMENT LIMITED23 set 200223 set 2002
    COUNTRY HOUSE INVESTMENTS LIMITED18 mar 199418 mar 1994
    CURSITOR (ONE HUNDRED AND TWENTY) LIMITED19 ott 199319 ott 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIBRENET SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FIBRENET SOLUTIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FIBRENET SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 lug 2013

    10 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    9 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * 19 Station Road Addlestone Surrey KT15 2AL* in data 20 giu 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 dic 2011

    Stato del capitale al 08 dic 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2011

    6 pagineAA

    legacy

    6 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2010

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2008

    5 pagineAA

    legacy

    6 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2007

    5 pagineAA

    legacy

    6 pagine363s

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed bunratty management LIMITED\certificate issued on 07/03/07
    3 pagineCERTNM

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2006

    5 pagineAA

    legacy

    6 pagine363s

    legacy

    9 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2005

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di FIBRENET SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TRAFFORD, Karen Elaine
    20 Lynwood Close
    GU21 5TJ Woodham
    Surrey
    Segretario
    20 Lynwood Close
    GU21 5TJ Woodham
    Surrey
    British110943660001
    TRAFFORD, Mark
    20 Lynwood Close
    GU21 5TJ Woodham
    Surrey
    Amministratore
    20 Lynwood Close
    GU21 5TJ Woodham
    Surrey
    United KingdomBritish104563250001
    CAREY, Sean
    7 Selbourne Close
    New Haw
    KT15 3RG Addlestone
    Surrey
    Segretario
    7 Selbourne Close
    New Haw
    KT15 3RG Addlestone
    Surrey
    British103661680001
    MOBBERLEY, Andrew George
    34 Wolseley Avenue
    SW19 8BQ London
    Segretario
    34 Wolseley Avenue
    SW19 8BQ London
    British71501390002
    SANDHU, Bimaljit Singh, Mr.
    56 Grange Road
    Ealing
    W5 5BX London
    Segretario
    56 Grange Road
    Ealing
    W5 5BX London
    British35609600002
    CURSITOR SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    2-3 Cursitor Street
    EC4A 1NE London
    Segretario nominato
    2-3 Cursitor Street
    EC4A 1NE London
    900006400001
    FINANCIAL AND LEGAL SERVICES LIMITED
    5th Floor Clement House
    14-18 Gresham Street
    EC2V 7JE London
    Segretario
    5th Floor Clement House
    14-18 Gresham Street
    EC2V 7JE London
    63025870001
    NOMINEE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    First Floor 21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    Segretario
    First Floor 21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    93514410001
    BELL, Stuart David
    Manor Way
    DA5 3QF Bexley
    18
    Kent
    Amministratore
    Manor Way
    DA5 3QF Bexley
    18
    Kent
    EnglandBritish4968910001
    BILTON, Anton John Godfrey
    46 Cadogan Place
    SW1X 9RU London
    Amministratore
    46 Cadogan Place
    SW1X 9RU London
    British21454000001
    BILTON, Laurence James
    312a Kings Rd
    Chelsea
    SW3 5UH London
    Amministratore
    312a Kings Rd
    Chelsea
    SW3 5UH London
    United KingdomBritish67947250001
    CAREY, Sean
    7 Selbourne Close
    New Haw
    KT15 3RG Addlestone
    Surrey
    Amministratore
    7 Selbourne Close
    New Haw
    KT15 3RG Addlestone
    Surrey
    British103661680001
    KRAUZE, Ben
    6 Rosemary Avenue
    Lower Earley
    RG6 2YQ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    6 Rosemary Avenue
    Lower Earley
    RG6 2YQ Reading
    Berkshire
    British40075840001
    MOBBERLEY, Andrew George
    34 Wolseley Avenue
    SW19 8BQ London
    Amministratore
    34 Wolseley Avenue
    SW19 8BQ London
    British71501390002
    SANDHU, Bimaljit Singh, Mr.
    56 Grange Road
    Ealing
    W5 5BX London
    Amministratore
    56 Grange Road
    Ealing
    W5 5BX London
    EnglandBritish35609600002
    SIMPSON, Steven James
    Hollybush House Part Lane
    Swallowfield
    RG7 1TD Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Hollybush House Part Lane
    Swallowfield
    RG7 1TD Reading
    Berkshire
    British2891760001
    CURSITOR NOMINEES LIMITED
    2-3 Cursitor Street
    EC4A 1NE London
    Amministratore delegato nominato
    2-3 Cursitor Street
    EC4A 1NE London
    900006390001
    CURSITOR SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    2-3 Cursitor Street
    EC4A 1NE London
    Amministratore delegato nominato
    2-3 Cursitor Street
    EC4A 1NE London
    900006400001
    NOMINEE SHARE SERVICES LIMITED
    First Floor 21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    Amministratore
    First Floor 21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    72308420001
    RAVEN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    First Floor
    21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    Amministratore
    First Floor
    21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    84584390001
    SANTON CLOSE NOMINEES LIMITED
    First Floor
    21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    Amministratore
    First Floor
    21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    84319870004

    FIBRENET SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 21 ott 2011
    Consegnato il 28 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 28 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge over construction contract
    Creato il 29 mar 1994
    Consegnato il 11 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due to the chargee from the company or any person who is a party to any related security document under or pursuant to the terms of the facility agreement, this deed or any related security document or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the right, title and interest of the company in a constructual contract dated 28/03/94 all sums payable under the contract the company's rights arising out of/or in connection with any breach or default by the contractor under the obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set-off
    Creato il 29 mar 1994
    Consegnato il 07 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The monies now or hereafter to be standing to the credit of any account of the company with the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1994
    Consegnato il 07 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as roffey park estate and adjoining land. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mar 1994
    Consegnato il 07 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First floating charge over the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FIBRENET SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 lug 2012Inizio della liquidazione
    23 set 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Rubin
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Praticante
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0