ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED

ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02864100
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GE CAPITAL MODULAR SPACE LIMITED18 gen 199918 gen 1999
    DBS NATIONWIDE PLC03 mag 199403 mag 1994
    DARCHEM BUILDING SYSTEMS LIMITED25 mar 199425 mar 1994
    MERONBOND LIMITED20 ott 199320 ott 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Elliott Group Ltd Elliott Group Ltd Manor Drive Peterborough Cambridgeshire PE4 7AP England

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Manor Drive Peterborough PE4 7AP in data 27 set 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 set 2013

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Cessazione della carica di Mark Andrew Eburne come amministratore in data 14 dic 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 ott 2012

    Stato del capitale al 23 ott 2012

    • Capitale: GBP 41,066,553
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    1 pagineAA

    Nomina di Ms Joana De Epalza come segretario in data 19 mar 2012

    1 pagineAP03

    Nomina di Ms Joana De Epalza come amministratore in data 19 mar 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Patrick Russell Thompson come amministratore in data 16 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Patrick Russell Thompson come segretario in data 16 mar 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 04 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Nomina di Mr Mark Andrew Eburne come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul O'kelly come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Ian Patrick Russell Thompson come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Ian Patrick Russell Thompson come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Anderson come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Thomas Anderson come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DE EPALZA, Joana
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Segretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    French171133460001
    DE EPALZA, Joana
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomFrenchDirector171133460001
    ANDERSON, Thomas
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    Segretario
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    BritishDirector1333060001
    GREENWOOD, Stuart Alan
    Winterley House
    Moorber House Coniston Cold
    BD23 4EQ Skipton
    Segretario
    Winterley House
    Moorber House Coniston Cold
    BD23 4EQ Skipton
    BritishDirector126211960001
    HARMAN, Christine
    20 Brookes Rise
    Langley Moor
    DH7 8XY Durham
    Segretario
    20 Brookes Rise
    Langley Moor
    DH7 8XY Durham
    BritishCompany Secretary39986630002
    HODGKISS, Roger Hilton
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    Segretario
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    BritishChartered Accountant76993260001
    JONES, Neil Robert
    30 Coniston Drive
    DN4 9GA Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    30 Coniston Drive
    DN4 9GA Doncaster
    South Yorkshire
    British76336200002
    LEE, Tony
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    British49293090003
    STANYARD, Miles Anthony
    Beckfarm House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QJ York
    North Yorkshire
    Segretario
    Beckfarm House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QJ York
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary67980710001
    THOMPSON, Ian Patrick Russell
    Manor Drive
    PE4 7AP Peterborough
    Elliott Group Ltd
    Cambridgeshire
    England
    Segretario
    Manor Drive
    PE4 7AP Peterborough
    Elliott Group Ltd
    Cambridgeshire
    England
    British148049290001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Segretario nominato
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    ANDERSON, Paul Michael
    The Old Laundry Cottage
    Poyle Road, Tongham
    GU10 1BS Farnham
    Surrey
    Amministratore
    The Old Laundry Cottage
    Poyle Road, Tongham
    GU10 1BS Farnham
    Surrey
    BritishManaging Director90129670002
    ANDERSON, Thomas
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    Amministratore
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    EnglandBritishCompany Director1333060001
    ATKINSON, Ralph
    9 Old Holt Road
    Medbourne
    LE16 8DY Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    9 Old Holt Road
    Medbourne
    LE16 8DY Market Harborough
    Leicestershire
    BritishRisk Director82227730002
    BROWN, Darren Paul
    47 Maple Avenue
    Crowle
    DN17 4ED Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Amministratore
    47 Maple Avenue
    Crowle
    DN17 4ED Scunthorpe
    North Lincolnshire
    EnglandBritishDirector88301430001
    BUCCI, John Vincent
    Summerhill
    Steels Lane, Oxshott
    KT22 0QQ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Summerhill
    Steels Lane, Oxshott
    KT22 0QQ Leatherhead
    Surrey
    AmericaDirector81623160001
    EBURNE, Mark Andrew
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    Amministratore
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    EnglandBritishDirector134516800001
    EDWARDS, David
    12 The Culvert
    Bradley Stoke
    BS32 8AB Bristol
    Avon
    Amministratore
    12 The Culvert
    Bradley Stoke
    BS32 8AB Bristol
    Avon
    BritishManaging Director113361520001
    EVANS, Geoffrey William
    21 Holme Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9DA Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Amministratore
    21 Holme Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9DA Scunthorpe
    North Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector18284320001
    FENTON, Jeffrey
    Gabriellalei 19
    Brasschaat
    2930 Antwerp
    Belgium
    Amministratore
    Gabriellalei 19
    Brasschaat
    2930 Antwerp
    Belgium
    AmericanPresident53202170002
    GILMORE, William
    19 Pirleyhill Gardens
    FK1 5NB Falkirk
    Sterlingshire
    Scotalnd
    Amministratore
    19 Pirleyhill Gardens
    FK1 5NB Falkirk
    Sterlingshire
    Scotalnd
    BritishInvestment Manager61928200001
    GLEGHORN, Michael, Ba (Hons)
    7 Beaufont Gardens
    Bawtry
    DN10 6RT Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    7 Beaufont Gardens
    Bawtry
    DN10 6RT Doncaster
    South Yorkshire
    BritishManaging Director69735130002
    GREENWOOD, Stuart Alan
    Winterley House
    Moorber House Coniston Cold
    BD23 4EQ Skipton
    Amministratore
    Winterley House
    Moorber House Coniston Cold
    BD23 4EQ Skipton
    EnglandBritishDirector126211960001
    HODGKISS, Roger Hilton
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    Amministratore
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    United KingdomBritishChartered Accountant76993260001
    HYMAN, James
    Oudstujderslei 16
    Brasschaat
    2930
    Belfium
    Amministratore
    Oudstujderslei 16
    Brasschaat
    2930
    Belfium
    BritishCompany Director62040380001
    JACKSON, Paul
    13-15 Low Road West
    Warmsworth
    DN4 9JZ Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    13-15 Low Road West
    Warmsworth
    DN4 9JZ Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director75000080001
    LEE, David John
    Van Leyenberghlaan 52
    9th Floor
    FOREIGN 1082 Gm Amsterdam
    The Netherlands
    Amministratore
    Van Leyenberghlaan 52
    9th Floor
    FOREIGN 1082 Gm Amsterdam
    The Netherlands
    BritishDirector65219710001
    MALOY, Brian
    Amsterdamstraat 14 Box W
    2000 Antwerp
    Belgium
    Amministratore
    Amsterdamstraat 14 Box W
    2000 Antwerp
    Belgium
    BritishFinance Dir53202240002
    MATTHEW, Jeremy
    Beethovenstraat 132-3
    FOREIGN Amsterdam
    1077 Js
    The Netherlands
    Amministratore
    Beethovenstraat 132-3
    FOREIGN Amsterdam
    1077 Js
    The Netherlands
    British And CanadianDirector115291490001
    MCNAMARA, Mary Jane
    96 Lake Rise
    RM1 4EE Gidea Park
    Essex
    Amministratore
    96 Lake Rise
    RM1 4EE Gidea Park
    Essex
    BritishDirector69295880001
    O'KELLY, Paul Brian
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    Amministratore
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    United KingdomBritishDirector184075280001
    OLIVER, John Lancaster
    Muhlgasse 11
    Berg
    Bayern 82335
    Germany
    Amministratore
    Muhlgasse 11
    Berg
    Bayern 82335
    Germany
    BritishDirector87846400001
    REILLY, Susan Mary
    5 Upper Glenburn Road
    Bearsden
    G61 4BW Glasgow
    Amministratore
    5 Upper Glenburn Road
    Bearsden
    G61 4BW Glasgow
    United KingdomBritishInvestment Management147127030001
    ROELOFS, Robert
    De Konning 4
    5258 KR Berlicum
    The Netherlands
    Amministratore
    De Konning 4
    5258 KR Berlicum
    The Netherlands
    DutchGeneral Counsel53202120001
    STANYARD, Miles Anthony
    Beckfarm House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QJ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beckfarm House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QJ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director67980710001

    ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage deed
    Creato il 23 gen 1997
    Consegnato il 24 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being land at sotherby road middlesborough cleveland t/no CE45026. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master agreement
    Creato il 01 nov 1996
    Consegnato il 02 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal assignment all the company's rights title and interest inthe sub-hire agreements, the specific contracts by way of equitable assignment the sub-hire agreements specific contracts and ancilliary contracts in respect of goods form time to time supplied under finance agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Leasing Limited
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    Transazioni
    • 02 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 05 giu 1996
    Consegnato il 14 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1. all the portable accommodation units (the chattels) described in the schedule to the mortgage deed together with any part or parts thereof and all additions and accessories etc. 2. the insurance policies entered into by the company 3. all the right title and interest in and to the benefit of all present and future contracts and agreements relating to the chattels.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 dic 1994
    Consegnato il 05 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Agreement no 157-053654-30 unit no es-20-1874 date of purchase 8/6/88. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mar 1994
    Consegnato il 06 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the asset sale agreement and/or this debenture
    Brevi particolari
    F/H-plot 2A pioneer works crabtree manor way south bexley kent t/n-SGL558401. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Darchem Contracting Limited
    • Pyrnoc Limited
    • R B Adda Systems Limited
    • Steelcraft Precision Tools Limited
    • West Auck No 4 Limited
    • Darchem Automation Limited
    • Darchem Buildings Systems Limited
    • West Auck No 1 Limited
    • Expert Industrial Controls Limited
    • Tooling Essentials Limited
    • Darchem Projects Limited
    • West Auck No 6 Limited
    • The Chemical & Insulating Company Limited
    • Structured Steel Systems Limited
    • West Auck No 5 Limited
    • West Auck No 3 Limited
    • Darchem Limited
    • Hilton Darchem Holdings Limited
    • William Baird PLC (As Agent and Trustee for Itself and the Following Companies)
    • West Auck No 7 Limited
    • Darchem Composite Structures
    • Darchem Scotswood Limited
    • Darchem Building Services Limited
    • Darchem Group Services
    • West Auck No 2 Limited
    Transazioni
    • 06 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 mar 1994
    Consegnato il 31 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-plot 2A pioneer works crabtree manor way south belvedere kent t/n-SGL558401 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 25 mar 1994
    Consegnato il 31 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 mar 1994
    Consegnato il 31 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land on the north east side of west auckland road darlington county durham t/n-DU14597 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 apr 2014Data di scioglimento
    13 set 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James Eldridge
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0