ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED
Panoramica
Nome della società | ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02864100 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GE CAPITAL MODULAR SPACE LIMITED | 18 gen 1999 | 18 gen 1999 |
DBS NATIONWIDE PLC | 03 mag 1994 | 03 mag 1994 |
DARCHEM BUILDING SYSTEMS LIMITED | 25 mar 1994 | 25 mar 1994 |
MERONBOND LIMITED | 20 ott 1993 | 20 ott 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | 4.71 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Elliott Group Ltd Elliott Group Ltd Manor Drive Peterborough Cambridgeshire PE4 7AP England | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Manor Drive Peterborough PE4 7AP in data 27 set 2013 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Risoluzione di insolvenza Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie" | 1 pagine | LIQ MISC RES | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Andrew Eburne come amministratore in data 14 dic 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Joana De Epalza come segretario in data 19 mar 2012 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Ms Joana De Epalza come amministratore in data 19 mar 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Patrick Russell Thompson come amministratore in data 16 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Patrick Russell Thompson come segretario in data 16 mar 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Andrew Eburne come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul O'kelly come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ian Patrick Russell Thompson come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Ian Patrick Russell Thompson come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Anderson come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Anderson come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE EPALZA, Joana | Segretario | More London Place SE1 2AF London 1 | French | 171133460001 | ||||||
DE EPALZA, Joana | Amministratore | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | French | Director | 171133460001 | ||||
ANDERSON, Thomas | Segretario | Manor Drive Peterborough PE4 7AP | British | Director | 1333060001 | |||||
GREENWOOD, Stuart Alan | Segretario | Winterley House Moorber House Coniston Cold BD23 4EQ Skipton | British | Director | 126211960001 | |||||
HARMAN, Christine | Segretario | 20 Brookes Rise Langley Moor DH7 8XY Durham | British | Company Secretary | 39986630002 | |||||
HODGKISS, Roger Hilton | Segretario | The Old Stables Ingthorne Lane South Milford LS25 5DH Leeds | British | Chartered Accountant | 76993260001 | |||||
JONES, Neil Robert | Segretario | 30 Coniston Drive DN4 9GA Doncaster South Yorkshire | British | 76336200002 | ||||||
LEE, Tony | Segretario | 8 Rossdale TN2 3PG Tunbridge Wells Kent | British | 49293090003 | ||||||
STANYARD, Miles Anthony | Segretario | Beckfarm House Marton Cum Grafton YO51 9QJ York North Yorkshire | British | Company Secretary | 67980710001 | |||||
THOMPSON, Ian Patrick Russell | Segretario | Manor Drive PE4 7AP Peterborough Elliott Group Ltd Cambridgeshire England | British | 148049290001 | ||||||
L & A SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
ANDERSON, Paul Michael | Amministratore | The Old Laundry Cottage Poyle Road, Tongham GU10 1BS Farnham Surrey | British | Managing Director | 90129670002 | |||||
ANDERSON, Thomas | Amministratore | Manor Drive Peterborough PE4 7AP | England | British | Company Director | 1333060001 | ||||
ATKINSON, Ralph | Amministratore | 9 Old Holt Road Medbourne LE16 8DY Market Harborough Leicestershire | British | Risk Director | 82227730002 | |||||
BROWN, Darren Paul | Amministratore | 47 Maple Avenue Crowle DN17 4ED Scunthorpe North Lincolnshire | England | British | Director | 88301430001 | ||||
BUCCI, John Vincent | Amministratore | Summerhill Steels Lane, Oxshott KT22 0QQ Leatherhead Surrey | America | Director | 81623160001 | |||||
EBURNE, Mark Andrew | Amministratore | Manor Drive Peterborough PE4 7AP | England | British | Director | 134516800001 | ||||
EDWARDS, David | Amministratore | 12 The Culvert Bradley Stoke BS32 8AB Bristol Avon | British | Managing Director | 113361520001 | |||||
EVANS, Geoffrey William | Amministratore | 21 Holme Drive Burton Upon Stather DN15 9DA Scunthorpe North Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 18284320001 | ||||
FENTON, Jeffrey | Amministratore | Gabriellalei 19 Brasschaat 2930 Antwerp Belgium | American | President | 53202170002 | |||||
GILMORE, William | Amministratore | 19 Pirleyhill Gardens FK1 5NB Falkirk Sterlingshire Scotalnd | British | Investment Manager | 61928200001 | |||||
GLEGHORN, Michael, Ba (Hons) | Amministratore | 7 Beaufont Gardens Bawtry DN10 6RT Doncaster South Yorkshire | British | Managing Director | 69735130002 | |||||
GREENWOOD, Stuart Alan | Amministratore | Winterley House Moorber House Coniston Cold BD23 4EQ Skipton | England | British | Director | 126211960001 | ||||
HODGKISS, Roger Hilton | Amministratore | The Old Stables Ingthorne Lane South Milford LS25 5DH Leeds | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 76993260001 | ||||
HYMAN, James | Amministratore | Oudstujderslei 16 Brasschaat 2930 Belfium | British | Company Director | 62040380001 | |||||
JACKSON, Paul | Amministratore | 13-15 Low Road West Warmsworth DN4 9JZ Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 75000080001 | ||||
LEE, David John | Amministratore | Van Leyenberghlaan 52 9th Floor FOREIGN 1082 Gm Amsterdam The Netherlands | British | Director | 65219710001 | |||||
MALOY, Brian | Amministratore | Amsterdamstraat 14 Box W 2000 Antwerp Belgium | British | Finance Dir | 53202240002 | |||||
MATTHEW, Jeremy | Amministratore | Beethovenstraat 132-3 FOREIGN Amsterdam 1077 Js The Netherlands | British And Canadian | Director | 115291490001 | |||||
MCNAMARA, Mary Jane | Amministratore | 96 Lake Rise RM1 4EE Gidea Park Essex | British | Director | 69295880001 | |||||
O'KELLY, Paul Brian | Amministratore | Manor Drive Peterborough PE4 7AP | United Kingdom | British | Director | 184075280001 | ||||
OLIVER, John Lancaster | Amministratore | Muhlgasse 11 Berg Bayern 82335 Germany | British | Director | 87846400001 | |||||
REILLY, Susan Mary | Amministratore | 5 Upper Glenburn Road Bearsden G61 4BW Glasgow | United Kingdom | British | Investment Management | 147127030001 | ||||
ROELOFS, Robert | Amministratore | De Konning 4 5258 KR Berlicum The Netherlands | Dutch | General Counsel | 53202120001 | |||||
STANYARD, Miles Anthony | Amministratore | Beckfarm House Marton Cum Grafton YO51 9QJ York North Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 67980710001 |
ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage deed | Creato il 23 gen 1997 Consegnato il 24 gen 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property being land at sotherby road middlesborough cleveland t/no CE45026. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Master agreement | Creato il 01 nov 1996 Consegnato il 02 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal assignment all the company's rights title and interest inthe sub-hire agreements, the specific contracts by way of equitable assignment the sub-hire agreements specific contracts and ancilliary contracts in respect of goods form time to time supplied under finance agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 05 giu 1996 Consegnato il 14 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1. all the portable accommodation units (the chattels) described in the schedule to the mortgage deed together with any part or parts thereof and all additions and accessories etc. 2. the insurance policies entered into by the company 3. all the right title and interest in and to the benefit of all present and future contracts and agreements relating to the chattels. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 30 dic 1994 Consegnato il 05 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Agreement no 157-053654-30 unit no es-20-1874 date of purchase 8/6/88. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 25 mar 1994 Consegnato il 06 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the asset sale agreement and/or this debenture | |
Brevi particolari F/H-plot 2A pioneer works crabtree manor way south bexley kent t/n-SGL558401. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 25 mar 1994 Consegnato il 31 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H-plot 2A pioneer works crabtree manor way south belvedere kent t/n-SGL558401 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 25 mar 1994 Consegnato il 31 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 25 mar 1994 Consegnato il 31 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H-land on the north east side of west auckland road darlington county durham t/n-DU14597 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
ELLIOTT MODULAR SPACE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0