WGP 100 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWGP 100 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02865476
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WGP 100 LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova WGP 100 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    27 Baker Street
    W1U 8AH London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WGP 100 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WESTON MEDICAL LIMITED01 feb 199401 feb 1994
    SORDINI LIMITED25 ott 199325 ott 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di WGP 100 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 gen 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per WGP 100 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    AU1K5VTI

    legacy

    1 pagineSH20
    A9PZ9V2D

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    A9PYUV2X

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 20 giu 2011

    • Capitale: GBP 0.01
    4 pagineSH19
    A4LBRV2Y

    Bilancio annuale redatto al 25 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    XR4PLOJ9

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John King il 18 ott 2010

    2 pagineCH01
    XOHCXOCB

    Conto per una società dormiente redatto al 30 gen 2010

    8 pagineAA
    A48ZYJPR

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John King il 16 nov 2009

    2 pagineCH01
    X1SL4F0U

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Anthony Gifford il 12 nov 2009

    2 pagineCH01
    X0MKPEW2

    Bilancio annuale redatto al 25 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    XTD76EIC

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John King il 29 ott 2009

    2 pagineCH01
    XTD74EIA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Donald Mccarthy il 29 ott 2009

    2 pagineCH01
    XTD75EIB

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Anthony Gifford il 29 ott 2009

    2 pagineCH01
    XTD73EI9

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Geoffrey Hearsey il 29 ott 2009

    1 pagineCH03
    XTD72EI8

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Deliberazione elettiva

    ELRES
    capital

    Risoluzioni

    Auth to sign accounts 18/06/2009
    RES13

    Bilancio redatto al 24 gen 2009

    8 pagineAA
    A5LE8AVR

    legacy

    1 pagine288c
    X4P648T1

    legacy

    4 pagine363a
    X1M2S4CU

    legacy

    1 pagine190
    X1M2R4CT

    legacy

    1 pagine353
    X1M2Q4CS

    legacy

    1 pagine287
    X1M2P4CR

    Bilancio redatto al 26 gen 2008

    8 pagineAA
    A2DE33U3

    Chi sono gli amministratori di WGP 100 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEARSEY, Peter Geoffrey
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    Segretario
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    British100685710010
    GIFFORD, Mark Anthony
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director87902570004
    KING, John
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director119328820004
    MCCARTHY, Donald
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director115152280003
    BATES, David Priestley
    Common Barn Mill Lane
    Stradbroke
    IP21 5HW Eye
    Suffolk
    Segretario
    Common Barn Mill Lane
    Stradbroke
    IP21 5HW Eye
    Suffolk
    BritishAccountant22204560001
    MALLETT, Andrew
    29 Saint Jamess Drive
    SW17 7RN London
    Segretario
    29 Saint Jamess Drive
    SW17 7RN London
    BritishChartered Accountant86193030001
    POMEROY, Julie Patricia
    The Shielings
    Highgrove Gardens
    NG12 4DF Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    The Shielings
    Highgrove Gardens
    NG12 4DF Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishChief Financial Officer87703450001
    THOMSON, Christopher John
    Bramblefield House
    Station Hill, Little Whelnetham
    IP30 0DT Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    Bramblefield House
    Station Hill, Little Whelnetham
    IP30 0DT Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British72127780002
    WAINE, Ian Michael
    The Spinney
    High Road Great Finborough
    IP14 3AA Stowmarket
    Suffolk
    Segretario
    The Spinney
    High Road Great Finborough
    IP14 3AA Stowmarket
    Suffolk
    BritishSolicitor93513490001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritishAccountant55757700003
    BATES, David Priestley
    Common Barn Mill Lane
    Stradbroke
    IP21 5HW Eye
    Suffolk
    Amministratore
    Common Barn Mill Lane
    Stradbroke
    IP21 5HW Eye
    Suffolk
    BritishAccountant22204560001
    BLAKER, Graham Joseph, Dr
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director110270002
    BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul
    20 Harold Road
    SE19 3PL London
    Amministratore
    20 Harold Road
    SE19 3PL London
    EnglandBritishChartered Accountant46232460002
    CASSAR, Stefan John
    22 Hazelwell Road
    SW15 6HL London
    Amministratore
    22 Hazelwell Road
    SW15 6HL London
    EnglandBritishCompany Director117062050001
    COLEMAN, John
    Lodge House Lodge House Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge House Lodge House Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritishAccountant56366250008
    DRAKE, John Arthur Courtney
    Manor Farm
    Witcombe
    TA12 6AJ Martock
    Somerset
    Amministratore
    Manor Farm
    Witcombe
    TA12 6AJ Martock
    Somerset
    EnglandBritishConsultant86344060001
    GIBBONS, David
    165 Elm Park Mansions
    Park Walk
    SW10 0AX London
    Amministratore
    165 Elm Park Mansions
    Park Walk
    SW10 0AX London
    United KingdomBritishNon Executive Director68823520001
    GORST, Jonathan Edward
    St Marys Main Road
    Martlesham
    IP12 4SJ Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    St Marys Main Road
    Martlesham
    IP12 4SJ Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritishSolicitor36521390001
    HOLLIDAY, Michael Francis
    Grange Farm
    Harvest Lane, Hindringham
    NR21 0PW Fakenham
    Norfolk
    Amministratore
    Grange Farm
    Harvest Lane, Hindringham
    NR21 0PW Fakenham
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director24337350002
    KING, Toby St John, Dr
    33 Maids Causeway
    CB5 8DE Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    33 Maids Causeway
    CB5 8DE Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishEngineer80054230001
    MANN, Khawar Amin
    107 Bramfield Road
    SW11 6PZ London
    Amministratore
    107 Bramfield Road
    SW11 6PZ London
    BritishDirector80214180001
    NEWMARCH, Michael George
    27 Paultons Square
    SW3 5DS London
    Amministratore
    27 Paultons Square
    SW3 5DS London
    BritishCompany Director1109560002
    POMEROY, Julie Patricia
    The Shielings
    Highgrove Gardens
    NG12 4DF Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Shielings
    Highgrove Gardens
    NG12 4DF Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChief Financial Officer87703450001
    SAMLER, Christopher Hadley
    The Old Rectory
    Creeton
    NG33 4QB Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Creeton
    NG33 4QB Grantham
    Lincolnshire
    EnglandBritishChief Executive54818550001
    SPICKSCHEN, Thorlef, Dr
    Traubenweg 25
    Seeheim
    64342
    Germany
    Amministratore
    Traubenweg 25
    Seeheim
    64342
    Germany
    GermanNon Executive Director80135950001
    WAINE, Ian Michael
    The Spinney
    High Road Great Finborough
    IP14 3AA Stowmarket
    Suffolk
    Amministratore
    The Spinney
    High Road Great Finborough
    IP14 3AA Stowmarket
    Suffolk
    United KingdomBritishSolicitor93513490001
    WESTON, Terence Edward
    Swannington Hall
    Church Lane, Swannington
    NR9 5NP Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Swannington Hall
    Church Lane, Swannington
    NR9 5NP Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director86432990001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    WGP 100 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 05 gen 2000
    Consegnato il 11 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £8,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £8,000.
    Persone aventi diritto
    • East of England Development Agency
    Transazioni
    • 11 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creato il 17 feb 1999
    Consegnato il 19 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4,582.00 standing to the credit of the deposit account opened by the landlord's solocitors rogers & norton with barclays bank PLC plain norwich norfolk from time to time
    Brevi particolari
    Rent deposit agreement under lease dated 5/2/99 in respect of unit 4B fuller road industrial estate fuller rd,harleston norfolk.
    Persone aventi diritto
    • David Jenkinson and Mary Ann Jenkinson
    Transazioni
    • 19 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge of intellectual property rights
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as trustee on behalf of the loan investors (as defined) and the noteholders (as defined) and to the noteholders and loan investors pursuant to the deed and/or the investments agreement and/or pursuant to the loan instrument
    Brevi particolari
    All patents and applications for patents,all intellectual property rights all rights title and interest in the trade marks all the materials for full details of charged assets please refer to form 395 (part iii of the schedule to the form). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in it's capacity as security trustee for the loan investors (as defined) and the noteholders (as defined) and to any of the loan investors and the noteholders pursuant to the loan instrument
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed of mortgage
    Creato il 25 set 1997
    Consegnato il 11 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the investment agreement, the supplemental investment agreement and/or the deed of mortgage as supplemented by the supplemental deed of mortgage
    Brevi particolari
    (A) save in respect of the intellectual property rights charged pursuant to clause 3.1(d) of the deed of mortgage has assigned absolutely to the lender to the extent that such rights are capable of assignment all of the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding expressly the third party rights but subject to and with benefit of the existing exploitation agreement to hold the same to the lender its successors and assigns absolutely for the free period during which such rights subsist throughout the world subject to the company's right of redemption pursuant to clause 6 of the deed of mortgage. Where any of the assigned rights are executory such assignment shall be construed as a present assignment of future rights;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canven (C.I.) Limited
    Transazioni
    • 11 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge of intellectual property rights and floating charge
    Creato il 25 set 1997
    Consegnato il 11 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights, all of the materials together with all of the equipment, by way of first floating charge the undertaking and all property and assets present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 set 1997
    Consegnato il 11 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the investment agreement and/or the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canven (C.I.) Limited
    Transazioni
    • 11 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage
    Creato il 25 set 1997
    Consegnato il 03 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an investment agreement dated 25TH september 1997 or under the debenture itself
    Brevi particolari
    Assignment of intellectual property rights with benefit of exploitation thereof undertaking to hold on trust those which cannot be assigned fixed charge on physical materials plant machinery and equipment intellectual property rights applications for such rights and book debts of the company. Equitable charge on physical materials to be created. Floating charge on all other assets.
    Persone aventi diritto
    • Michael Francis Holliday
    Transazioni
    • 03 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 set 1997
    Consegnato il 03 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an investment agreement dated 25TH september 1997 or under the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael Francis Holliday
    Transazioni
    • 03 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 1996
    Consegnato il 18 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the investment agreement and/or this deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canven (C.I.) Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage
    Creato il 29 nov 1996
    Consegnato il 18 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the investment agreement and/or this deed
    Brevi particolari
    Part of the physcial materials charges all plant machinery and equipment relating to the intellectual property rights or the third party rights or the physical materials all the intellectual property rights all book debts and other debts floating charge over the undertaking and property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canven (C.I.) Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of and fixed charge over intellectual property rights
    Creato il 06 ago 1996
    Consegnato il 23 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all other sums intended to be secured in deeds of assignment of intellectual property rights and floating charges dated 14TH january 1994, 2ND october 1995 and 10TH april 1996 (the "previous deeds")
    Brevi particolari
    First fixed charge on all the company's right title and interest in and to (a). The patents and (b) the intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 23 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Creato il 10 apr 1996
    Consegnato il 12 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment of all of the company's right, title and interest in and to the intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Creato il 02 ott 1995
    Consegnato il 19 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest in and to the intellectual property rights floating charge over all the other undertaking and other property assets of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights andfloating charge
    Creato il 14 gen 1994
    Consegnato il 21 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment of all the company's right title and interest in and to the intellectual,property rights as specified. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 gen 1994
    Consegnato il 19 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WGP 100 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 feb 2003Inizio dell'amministrazione
    14 giu 2005Amministrazione scaricata
    Ordine di amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan Watson Graham
    Acquis Court
    31 Fishpool Street
    AL3 4RF St Albans
    Praticante
    Acquis Court
    31 Fishpool Street
    AL3 4RF St Albans
    Jane Bronwen Moriarty
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Praticante
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    2
    DataTipo
    28 nov 2003Data della riunione per approvare il CVA
    13 mag 2005Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan Watson Graham
    Acquis Court
    31 Fishpool Street
    AL3 4RF St Albans
    Praticante
    Acquis Court
    31 Fishpool Street
    AL3 4RF St Albans
    Jane Bronwen Moriarty
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Praticante
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0