EXCLUSIVE GROUP LIMITED

EXCLUSIVE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXCLUSIVE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02865823
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXCLUSIVE GROUP LIMITED?

    • Servizi di rimozione (49420) / Trasporto e stoccaggio
    • Operazione di strutture di stoccaggio e deposito per attività di trasporto via terra (52103) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova EXCLUSIVE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Oriental Road
    E16 2BZ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXCLUSIVE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EXCLUSIVE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY23 nov 199423 nov 1994
    AUTOCHAIN LIMITED25 ott 199325 ott 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXCLUSIVE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per EXCLUSIVE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Adam Thomas Councell come amministratore in data 18 giu 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Harvey Jack Samson come amministratore in data 18 giu 2012

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    11 pagineMG01

    legacy

    11 pagineMG01
    Note
    DataNota
    12 mar 2012Other This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2012 al 31 dic 2011

    3 pagineAA01

    Nomina di Mr Charles Antony Lawrence Skinner come amministratore in data 29 feb 2012

    3 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The director of the company authorised the power conferred upon them by section 175 of the companies act 2006. 29/02/2012
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    11 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    15 pagineAA

    Nomina di Mr Harvey Jack Samson come amministratore in data 29 feb 2012

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 - 4 Cooks Road London E15 2PW United Kingdom in data 03 gen 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 ott 2011

    Stato del capitale al 25 ott 2011

    • Capitale: GBP 550,222
    SH01

    Nomina di Mr James Hannaford come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di EXCLUSIVE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COUNCELL, Adam Thomas
    Oriental Road
    E16 2BZ London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Oriental Road
    E16 2BZ London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritish148675630002
    DEWS, Nigel
    Oriental Road
    E16 2BZ London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Oriental Road
    E16 2BZ London
    2
    United Kingdom
    Great BritainBritish148913280001
    HANNAFORD, James Murray
    Oriental Road
    E16 2BZ London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Oriental Road
    E16 2BZ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish86844030002
    SKINNER, Charles Antony Lawrence
    Moorhouse Road
    W2 5DH London
    13
    United Kingdom
    Amministratore
    Moorhouse Road
    W2 5DH London
    13
    United Kingdom
    EnglandBritish58948170002
    BIGGS, Christopher Paul
    Ems House
    Cooks Road
    E15 2PW London
    Segretario
    Ems House
    Cooks Road
    E15 2PW London
    British80042960001
    GABE WILKINSON, Charles
    77c Belsize Park Gardens
    Belsize Park
    NW3 5JP London
    Segretario
    77c Belsize Park Gardens
    Belsize Park
    NW3 5JP London
    British57777290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BIGGS, Christopher Paul
    Ems House
    Cooks Road
    E15 2PW London
    Amministratore
    Ems House
    Cooks Road
    E15 2PW London
    EnglandBritish80042960001
    BIRKBY, Howard
    24 Newall Hall Park
    LS21 2RD Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    24 Newall Hall Park
    LS21 2RD Otley
    West Yorkshire
    British2131780001
    CARR, Andrew Kevin
    Ems House
    Cooks Road
    E15 2PW London
    Amministratore
    Ems House
    Cooks Road
    E15 2PW London
    EnglandBritish82575740001
    CLIFFORD, Daniel Joseph
    12 Broadoak Avenue
    EN3 6TS Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    12 Broadoak Avenue
    EN3 6TS Enfield
    Middlesex
    British27861590001
    GABE WILKINSON, Charles
    77c Belsize Park Gardens
    Belsize Park
    NW3 5JP London
    Amministratore
    77c Belsize Park Gardens
    Belsize Park
    NW3 5JP London
    British57777290001
    LAMB, Anthony Noel
    14 The Droveway
    RH16 1LL Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    14 The Droveway
    RH16 1LL Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish4559200001
    LEWIS, Frank
    14 Franklin Close
    N20 9QG Whetstone
    London
    Amministratore
    14 Franklin Close
    N20 9QG Whetstone
    London
    United KingdomBritish55302020001
    MICHAEL, Stuart Roy
    Stoneways
    60 Aldenham Avenue
    WD7 8HY Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Stoneways
    60 Aldenham Avenue
    WD7 8HY Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish11653160001
    SAMSON, Harvey Jack
    Unit 5 Redhill Distribution Centre
    Salbrook Road
    Redhill
    The Databank
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 5 Redhill Distribution Centre
    Salbrook Road
    Redhill
    The Databank
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish3650740002
    SEAGER, Edward Gavin
    The Barn
    The Green, Easton
    BA5 1EB Wells
    Somerset
    Amministratore
    The Barn
    The Green, Easton
    BA5 1EB Wells
    Somerset
    British61402270001
    STEPHENS, Nigel Conway
    The Terraces 63 Downlands Road
    CR8 4JJ Purley
    Surrey
    Amministratore
    The Terraces 63 Downlands Road
    CR8 4JJ Purley
    Surrey
    British49053460002
    STUDD, Ian James
    1 Victoria Road
    CM9 5HE Maldon
    Essex
    Amministratore
    1 Victoria Road
    CM9 5HE Maldon
    Essex
    United KingdomBritish81462100001
    TAYLOR, John Edward
    8 Beaufort Close
    RM7 8DD Romford
    Amministratore
    8 Beaufort Close
    RM7 8DD Romford
    British69464630001
    UPSDELL, Geoffrey Graham
    Windyridge Braintree Road
    CM6 1HU Great Dunmow
    Essex
    Amministratore
    Windyridge Braintree Road
    CM6 1HU Great Dunmow
    Essex
    British27940960001
    WHITEHEAD, Mark
    28 Hubert Road
    RM13 8AB Rainham
    Essex
    Amministratore
    28 Hubert Road
    RM13 8AB Rainham
    Essex
    British65345470001
    WILKINS, Stephen
    - 4
    Cooks Road
    E15 2PW London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    - 4
    Cooks Road
    E15 2PW London
    1
    United Kingdom
    United KingdomEnglish151467020001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    EXCLUSIVE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession and charge
    Creato il 01 mar 2012
    Consegnato il 09 mar 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all the other companies to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 29 feb 2012
    Consegnato il 13 mar 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 28 feb 2012
    Consegnato il 07 mar 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 16TH february 2001
    Creato il 10 nov 2005
    Consegnato il 12 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present anf future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 16TH february 2001 and
    Creato il 26 set 2002
    Consegnato il 10 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture deed
    Creato il 26 set 2002
    Consegnato il 10 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture deed
    Creato il 15 ago 2002
    Consegnato il 16 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 16 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 30 ago 1996
    Consegnato il 09 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any factoring or invoice discounting agreement or arrangement or any loan or leasing agreement or arrangement or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finance LTD
    Transazioni
    • 09 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 14 ott 1994
    Consegnato il 22 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0