EXCLUSIVE GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EXCLUSIVE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02865823 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EXCLUSIVE GROUP LIMITED?
- Servizi di rimozione (49420) / Trasporto e stoccaggio
- Operazione di strutture di stoccaggio e deposito per attività di trasporto via terra (52103) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova EXCLUSIVE GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2 Oriental Road E16 2BZ London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EXCLUSIVE GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EXCLUSIVE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 23 nov 1994 | 23 nov 1994 |
| AUTOCHAIN LIMITED | 25 ott 1993 | 25 ott 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EXCLUSIVE GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per EXCLUSIVE GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG04 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG04 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG04 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Nomina di Adam Thomas Councell come amministratore in data 18 giu 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Harvey Jack Samson come amministratore in data 18 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Varie Section 519 | 1 pagine | MISC | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 11 pagine | MG01 | ||||||||||||||
legacy | 11 pagine | MG01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2012 al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Charles Antony Lawrence Skinner come amministratore in data 29 feb 2012 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 11 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 11 pagine | MG01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Harvey Jack Samson come amministratore in data 29 feb 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 - 4 Cooks Road London E15 2PW United Kingdom in data 03 gen 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Mr James Hannaford come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di EXCLUSIVE GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNCELL, Adam Thomas | Amministratore | Oriental Road E16 2BZ London 2 United Kingdom | England | British | 148675630002 | |||||
| DEWS, Nigel | Amministratore | Oriental Road E16 2BZ London 2 United Kingdom | Great Britain | British | 148913280001 | |||||
| HANNAFORD, James Murray | Amministratore | Oriental Road E16 2BZ London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 86844030002 | |||||
| SKINNER, Charles Antony Lawrence | Amministratore | Moorhouse Road W2 5DH London 13 United Kingdom | England | British | 58948170002 | |||||
| BIGGS, Christopher Paul | Segretario | Ems House Cooks Road E15 2PW London | British | 80042960001 | ||||||
| GABE WILKINSON, Charles | Segretario | 77c Belsize Park Gardens Belsize Park NW3 5JP London | British | 57777290001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BIGGS, Christopher Paul | Amministratore | Ems House Cooks Road E15 2PW London | England | British | 80042960001 | |||||
| BIRKBY, Howard | Amministratore | 24 Newall Hall Park LS21 2RD Otley West Yorkshire | British | 2131780001 | ||||||
| CARR, Andrew Kevin | Amministratore | Ems House Cooks Road E15 2PW London | England | British | 82575740001 | |||||
| CLIFFORD, Daniel Joseph | Amministratore | 12 Broadoak Avenue EN3 6TS Enfield Middlesex | British | 27861590001 | ||||||
| GABE WILKINSON, Charles | Amministratore | 77c Belsize Park Gardens Belsize Park NW3 5JP London | British | 57777290001 | ||||||
| LAMB, Anthony Noel | Amministratore | 14 The Droveway RH16 1LL Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 4559200001 | |||||
| LEWIS, Frank | Amministratore | 14 Franklin Close N20 9QG Whetstone London | United Kingdom | British | 55302020001 | |||||
| MICHAEL, Stuart Roy | Amministratore | Stoneways 60 Aldenham Avenue WD7 8HY Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 11653160001 | |||||
| SAMSON, Harvey Jack | Amministratore | Unit 5 Redhill Distribution Centre Salbrook Road Redhill The Databank Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 3650740002 | |||||
| SEAGER, Edward Gavin | Amministratore | The Barn The Green, Easton BA5 1EB Wells Somerset | British | 61402270001 | ||||||
| STEPHENS, Nigel Conway | Amministratore | The Terraces 63 Downlands Road CR8 4JJ Purley Surrey | British | 49053460002 | ||||||
| STUDD, Ian James | Amministratore | 1 Victoria Road CM9 5HE Maldon Essex | United Kingdom | British | 81462100001 | |||||
| TAYLOR, John Edward | Amministratore | 8 Beaufort Close RM7 8DD Romford | British | 69464630001 | ||||||
| UPSDELL, Geoffrey Graham | Amministratore | Windyridge Braintree Road CM6 1HU Great Dunmow Essex | British | 27940960001 | ||||||
| WHITEHEAD, Mark | Amministratore | 28 Hubert Road RM13 8AB Rainham Essex | British | 65345470001 | ||||||
| WILKINS, Stephen | Amministratore | - 4 Cooks Road E15 2PW London 1 United Kingdom | United Kingdom | English | 151467020001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
EXCLUSIVE GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge | Creato il 01 mar 2012 Consegnato il 09 mar 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and all the other companies to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and fixed and floating charge | Creato il 29 feb 2012 Consegnato il 13 mar 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and fixed and floating charge | Creato il 28 feb 2012 Consegnato il 07 mar 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 16TH february 2001 | Creato il 10 nov 2005 Consegnato il 12 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present anf future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 16TH february 2001 and | Creato il 26 set 2002 Consegnato il 10 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 26 set 2002 Consegnato il 10 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| All assets debenture deed | Creato il 15 ago 2002 Consegnato il 16 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 30 ago 1996 Consegnato il 09 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under any factoring or invoice discounting agreement or arrangement or any loan or leasing agreement or arrangement or on any other account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 14 ott 1994 Consegnato il 22 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0