TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED

TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02866179
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACDTRIDON EUROPE LIMITED29 mag 199629 mag 1996
    AUTOMOTIVE COMPONENTS DUNSTABLE LIMITED14 dic 199314 dic 1993
    PIRGOS LIMITED26 ott 199326 ott 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Cessazione della carica di Coral Suzanne Bidel come amministratore in data 22 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daniel Marc Richard Jaffe come amministratore in data 09 lug 2015

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU a Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY in data 12 dic 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 nov 2014

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 dic 2014

    Stato del capitale al 09 dic 2014

    • Capitale: GBP 22,903,734
    SH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 10 ott 2014

    • Capitale: GBP 22,903,734
    3 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Nicolas Paul Wilkinson come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas C. Reeve come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elizabeth Honor Lewzey come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Coral Bidel il 05 set 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Daniel Marc Richard Jaffe come amministratore in data 13 ago 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Intertrust (Uk) Limited come segretario in data 13 ago 2014

    2 pagineAP04

    Nomina di Miss Coral Bidel come amministratore in data 13 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Honor Lewzey come segretario in data 13 ago 2014

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE a 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU in data 22 ago 2014

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 dic 2013

    Stato del capitale al 10 dic 2013

    • Capitale: GBP 18,010,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Segretario
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06307550
    188126550001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    Segretario
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157101930001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Segretario
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833360001
    SHORTT, Eugene
    50 Green Drift
    SG8 5BX Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    50 Green Drift
    SG8 5BX Royston
    Hertfordshire
    British4764420001
    YEOMANS, Alan Richard
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    Segretario
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    British26276020001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    ABBOTT, Brian Arthur
    18 Alma Farm Road
    Toddington
    LU5 6BG Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    18 Alma Farm Road
    Toddington
    LU5 6BG Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish38296100001
    BIDEL, Coral Suzanne
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Amministratore
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish179297460002
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    CAREY, Stephen James
    145 High Street
    Harrold
    MK43 7ED Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    145 High Street
    Harrold
    MK43 7ED Bedford
    Bedfordshire
    British76189900002
    CORPATAUX, Beat Eugene
    Marly Strasse 3
    CH 17 34 Tentlingen
    Switzerland
    Amministratore
    Marly Strasse 3
    CH 17 34 Tentlingen
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss49248640001
    DRUMMOND, David Fraser
    3 St Anthony's Close
    RG12 2EB Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    3 St Anthony's Close
    RG12 2EB Bracknell
    Berkshire
    British43960000001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    Amministratore
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HILLSON, Anthony Leonard
    18 Tavistock Avenue
    Ampthill
    MK45 2RY Bedford
    Amministratore
    18 Tavistock Avenue
    Ampthill
    MK45 2RY Bedford
    British43960090001
    HOFMANN, Helmut
    12
    Meadow Height Crt
    L4J 1V6 Thornhill
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    12
    Meadow Height Crt
    L4J 1V6 Thornhill
    Ontario
    Canada
    Canadian46601750001
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Amministratore
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOTTINGER, Michael
    5000 Country Club Drive
    37027 Brentwood
    Tennessee
    Usa
    Amministratore
    5000 Country Club Drive
    37027 Brentwood
    Tennessee
    Usa
    American46550450001
    JAFFE, Daniel Marc Richard
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Amministratore
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish140811810001
    KEECH, Craig William
    174 Slad Road
    GL5 1RJ Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    174 Slad Road
    GL5 1RJ Stroud
    Gloucestershire
    British45367870003
    KEECH, Dennis
    216 Old Bedford Road
    LU2 7HP Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    216 Old Bedford Road
    LU2 7HP Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritish24425650001
    KEECH, Matthew David
    36 Statham Close
    LU3 4EJ Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    36 Statham Close
    LU3 4EJ Luton
    Bedfordshire
    British38296150001
    KINGSBURGH, Murray
    31 Warlock Crescent
    MKU 2H8 Willowdale
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    31 Warlock Crescent
    MKU 2H8 Willowdale
    Ontario
    Canada
    Canadian46550570001
    LANGSHAW, Ralph
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    British37169710001
    LANGSHAW, Ralph
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    British37169710001
    LEE, Norman Holt
    9 Compgate
    Eaton Bray
    LU6 2AU Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    9 Compgate
    Eaton Bray
    LU6 2AU Dunstable
    Bedfordshire
    British38296170001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MUSHTAQ, Mohammed Arif
    13 Edkins Close
    Bushmead
    LU2 7SS Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    13 Edkins Close
    Bushmead
    LU2 7SS Luton
    Bedfordshire
    British42865020001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    REEVE, Thomas C.
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    United StatesAmerican161822390001
    RENNER, James
    3453 Sawmill Valley Drive
    LSL 3A3 Mississauga
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    3453 Sawmill Valley Drive
    LSL 3A3 Mississauga
    Ontario
    Canada
    Canadian46550730001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish48808690001
    YEOMANS, Alan Richard
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    Amministratore
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    British26276020001
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001

    TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 30 set 2010
    Consegnato il 15 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust Fsb (The Collateral Agent)
    Transazioni
    • 15 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 30 set 2010
    Consegnato il 13 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Usa, Inc. (The Collateral Agent)
    Transazioni
    • 13 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of composite guarantee and debenture
    Creato il 08 feb 1996
    Consegnato il 23 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tridon limited,the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    All right title estate and other interests of the chargor in or over a lease dated 29TH january 1996 of land and buildings situate on the south west of high street north dunstable bedfordshire and all plant and machinery and all assets charged and assigned as outlined on the form 395 and attached schedules please see form for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia
    Transazioni
    • 23 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 feb 1994
    Consegnato il 16 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The assigns the goodwill of the business to the bank the benefit of any licences all intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage and specific charge
    Creato il 08 feb 1994
    Consegnato il 16 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and every interest in or over a lease dated 4/2/94 of land and buildings on the south west of high street north dunstable bedfordshire and situate and k/a the waterloo sports ground high street north dunstable bedfordshire t/no'SBD95171 and BD26409 all rights under an option agreement dated 4/2/94. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 nov 2014Inizio della liquidazione
    23 feb 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Praticante
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0