TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02866179 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ACDTRIDON EUROPE LIMITED | 29 mag 1996 | 29 mag 1996 |
| AUTOMOTIVE COMPONENTS DUNSTABLE LIMITED | 14 dic 1993 | 14 dic 1993 |
| PIRGOS LIMITED | 26 ott 1993 | 26 ott 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | 4.71 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Coral Suzanne Bidel come amministratore in data 22 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Marc Richard Jaffe come amministratore in data 09 lug 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU a Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY in data 12 dic 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||||||
Risoluzione di insolvenza Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie" | 1 pagine | LIQ MISC RES | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 10 ott 2014
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nicolas Paul Wilkinson come amministratore in data 30 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Thomas C. Reeve come amministratore in data 30 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Honor Lewzey come amministratore in data 30 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Coral Bidel il 05 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Daniel Marc Richard Jaffe come amministratore in data 13 ago 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Intertrust (Uk) Limited come segretario in data 13 ago 2014 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||
Nomina di Miss Coral Bidel come amministratore in data 13 ago 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Honor Lewzey come segretario in data 13 ago 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE a 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU in data 22 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Segretario | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry United Kingdom |
| 188126550001 | ||||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Segretario | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Segretario | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157101930001 | |||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Segretario | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833360001 | |||||||||||
| SHORTT, Eugene | Segretario | 50 Green Drift SG8 5BX Royston Hertfordshire | British | 4764420001 | ||||||||||
| YEOMANS, Alan Richard | Segretario | 16 Long Massey MK46 5NR Olney Buckinghamshire | British | 26276020001 | ||||||||||
| CMH SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000940001 | |||||||||||
| ABBOTT, Brian Arthur | Amministratore | 18 Alma Farm Road Toddington LU5 6BG Dunstable Bedfordshire | England | British | 38296100001 | |||||||||
| BIDEL, Coral Suzanne | Amministratore | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 179297460002 | |||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Amministratore | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||||||
| CAREY, Stephen James | Amministratore | 145 High Street Harrold MK43 7ED Bedford Bedfordshire | British | 76189900002 | ||||||||||
| CORPATAUX, Beat Eugene | Amministratore | Marly Strasse 3 CH 17 34 Tentlingen Switzerland | Switzerland | Swiss | 49248640001 | |||||||||
| DRUMMOND, David Fraser | Amministratore | 3 St Anthony's Close RG12 2EB Bracknell Berkshire | British | 43960000001 | ||||||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Amministratore | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||||||
| HILLSON, Anthony Leonard | Amministratore | 18 Tavistock Avenue Ampthill MK45 2RY Bedford | British | 43960090001 | ||||||||||
| HOFMANN, Helmut | Amministratore | 12 Meadow Height Crt L4J 1V6 Thornhill Ontario Canada | Canadian | 46601750001 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Amministratore | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||||||
| HOTTINGER, Michael | Amministratore | 5000 Country Club Drive 37027 Brentwood Tennessee Usa | American | 46550450001 | ||||||||||
| JAFFE, Daniel Marc Richard | Amministratore | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 140811810001 | |||||||||
| KEECH, Craig William | Amministratore | 174 Slad Road GL5 1RJ Stroud Gloucestershire | British | 45367870003 | ||||||||||
| KEECH, Dennis | Amministratore | 216 Old Bedford Road LU2 7HP Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | 24425650001 | |||||||||
| KEECH, Matthew David | Amministratore | 36 Statham Close LU3 4EJ Luton Bedfordshire | British | 38296150001 | ||||||||||
| KINGSBURGH, Murray | Amministratore | 31 Warlock Crescent MKU 2H8 Willowdale Ontario Canada | Canadian | 46550570001 | ||||||||||
| LANGSHAW, Ralph | Amministratore | Westway 71a West Common AL5 2LD Harpenden Hertfordshire | British | 37169710001 | ||||||||||
| LANGSHAW, Ralph | Amministratore | Westway 71a West Common AL5 2LD Harpenden Hertfordshire | British | 37169710001 | ||||||||||
| LEE, Norman Holt | Amministratore | 9 Compgate Eaton Bray LU6 2AU Dunstable Bedfordshire | British | 38296170001 | ||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Amministratore | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Amministratore | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||||||
| MUSHTAQ, Mohammed Arif | Amministratore | 13 Edkins Close Bushmead LU2 7SS Luton Bedfordshire | British | 42865020001 | ||||||||||
| PORTER, Norman Charles | Amministratore | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||||||
| REEVE, Thomas C. | Amministratore | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||||||
| RENNER, James | Amministratore | 3453 Sawmill Valley Drive LSL 3A3 Mississauga Ontario Canada | Canadian | 46550730001 | ||||||||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Amministratore | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||||||
| YEOMANS, Alan Richard | Amministratore | 16 Long Massey MK46 5NR Olney Buckinghamshire | British | 26276020001 | ||||||||||
| CMH DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000930001 |
TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Creato il 30 set 2010 Consegnato il 15 ott 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 30 set 2010 Consegnato il 13 ott 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of composite guarantee and debenture | Creato il 08 feb 1996 Consegnato il 23 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from tridon limited,the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed | |
Brevi particolari All right title estate and other interests of the chargor in or over a lease dated 29TH january 1996 of land and buildings situate on the south west of high street north dunstable bedfordshire and all plant and machinery and all assets charged and assigned as outlined on the form 395 and attached schedules please see form for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 08 feb 1994 Consegnato il 16 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The assigns the goodwill of the business to the bank the benefit of any licences all intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage and specific charge | Creato il 08 feb 1994 Consegnato il 16 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and every interest in or over a lease dated 4/2/94 of land and buildings on the south west of high street north dunstable bedfordshire and situate and k/a the waterloo sports ground high street north dunstable bedfordshire t/no'SBD95171 and BD26409 all rights under an option agreement dated 4/2/94. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0