TRAMSCOM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRAMSCOM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02867254
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRAMSCOM LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TRAMSCOM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Derwent House
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRAMSCOM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CANCOM LIMITED04 set 200004 set 2000
    MULTIPLE ZONES LTD.29 ott 199329 ott 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRAMSCOM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TRAMSCOM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Titchfield House, 2nd Floor 69/85 Tabernacle Street London EC2A 4BD England a New Derwent House 69-73 Theobalds Road London WC1X 8TA in data 13 nov 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 69-85 Haines Watts (City) Llp Titchfield House Tabernacle Street London EC2A 4BD England a Titchfield House, 2nd Floor 69/85 Tabernacle Street London EC2A 4BD in data 21 mar 2019

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Titchfield House, 2nd Floor 69/85 Tabernacle Street London EC2A 4BD England a 69-85 Haines Watts (City) Llp Titchfield House Tabernacle Street London EC2A 4BD in data 20 mar 2019

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Titchfield House, 2nd Floor 69/85 Tabernacle Street London EC2A 4BD England a Titchfield House, 2nd Floor 69/85 Tabernacle Street London EC2A 4BD in data 19 mar 2019

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Coldbath Square London EC1R 5HL a Titchfield House, 2nd Floor 69/85 Tabernacle Street London EC2A 4BD in data 18 mar 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2017 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2015, revisionato

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 nov 2015

    Stato del capitale al 18 nov 2015

    • Capitale: GBP 879,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 nov 2014

    Stato del capitale al 21 nov 2014

    • Capitale: GBP 879,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2013

    Stato del capitale al 04 nov 2013

    • Capitale: GBP 879,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di TRAMSCOM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PAGE, Alexander Roland Henry
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    New Derwent House
    England
    Segretario
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    New Derwent House
    England
    169319290001
    PAGE, Alexander Roland Henry
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    New Derwent House
    England
    Amministratore
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    New Derwent House
    England
    United KingdomBritishCompany Director91005030002
    PEEL, Warren Michael
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    New Derwent House
    England
    Amministratore
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    New Derwent House
    England
    United KingdomBritishCompany Director92370520006
    WEIGHTMAN, Brandon Clive
    65 Orchard Close
    Fetcham
    KT22 9JB Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    65 Orchard Close
    Fetcham
    KT22 9JB Leatherhead
    Surrey
    BritishAccountant65884820001
    WRIGHT, Maxwell Derek
    Pine Court
    Woodpecker Way
    GU22 0SG Woking
    Surrey
    Segretario
    Pine Court
    Woodpecker Way
    GU22 0SG Woking
    Surrey
    BritishBusiness Consultant18805060002
    WRIGHT, Shirley Anne
    Grove Heath Farm Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6ES Woking
    Surrey
    Segretario
    Grove Heath Farm Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6ES Woking
    Surrey
    British18805050001
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001
    HINES JR, Robert Lee
    2116 3rd Ave N
    Seattle 98109
    FOREIGN Washington Usa
    Amministratore
    2116 3rd Ave N
    Seattle 98109
    FOREIGN Washington Usa
    UsaCompany Director55327180001
    KABANI, Sadru
    4296 East Mercer Way
    WA98040 Mercer Island
    Usa
    Amministratore
    4296 East Mercer Way
    WA98040 Mercer Island
    Usa
    BritishCompany President And Ceo38398780001
    KABANI, Sadrudin
    4648-95th Avenue Ne
    FOREIGN Bellevue 98004 Washington Usa
    Amministratore
    4648-95th Avenue Ne
    FOREIGN Bellevue 98004 Washington Usa
    UsChairman60287980001
    LEAKE, Gary Barton
    4307 209th Ave Ne
    Redmond 98053
    FOREIGN Washington Usa
    Amministratore
    4307 209th Ave Ne
    Redmond 98053
    FOREIGN Washington Usa
    BritishVice President55223900001
    MAYR, Martin Herrman
    Dillingen Donan
    Geschwrister-Scholl-Strasse 4
    D-89407
    Germany
    Amministratore
    Dillingen Donan
    Geschwrister-Scholl-Strasse 4
    D-89407
    Germany
    GermanyGermanConsultant133424800001
    MCFADDEN, Ronald Patrick
    8450 Se 47th Place
    Mercer Island 98040 Washington Usa
    Amministratore
    8450 Se 47th Place
    Mercer Island 98040 Washington Usa
    United StatesAmericanVice President60288730001
    MODJTABAI, Ramin
    318 Platinum House
    Lyon Road
    HA1 2EX Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    318 Platinum House
    Lyon Road
    HA1 2EX Harrow
    Middlesex
    UsaSales93010410001
    OLLEY, Trevor Leonard
    Wealden Cottage
    Mapledrakes Road Ewhurst
    GU6 7QP Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Wealden Cottage
    Mapledrakes Road Ewhurst
    GU6 7QP Cranleigh
    Surrey
    BritishDirector125670180001
    WEIGHTMAN, Brandon Clive
    65 Orchard Close
    Fetcham
    KT22 9JB Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    65 Orchard Close
    Fetcham
    KT22 9JB Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishAccountant65884820001
    WILLIAMS, James Storie
    68 Grovelands Road
    RG30 2NY Reading
    Berkshire
    Amministratore
    68 Grovelands Road
    RG30 2NY Reading
    Berkshire
    BritishDirector38655930001
    WRIGHT, Maxwell Derek
    Pine Court
    Woodpecker Way
    GU22 0SG Woking
    Surrey
    Amministratore
    Pine Court
    Woodpecker Way
    GU22 0SG Woking
    Surrey
    EnglandBritishBusiness Consultant18805060002
    COMPUTER ZONES LIMITED
    Genesis House
    Merrow Lane
    GU4 7BN Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Genesis House
    Merrow Lane
    GU4 7BN Guildford
    Surrey
    65884850001
    PENTEL COMPUTER SERVICES LIMITED
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    3
    England
    Amministratore
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    3
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04792775
    168152030001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TRAMSCOM LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Trams Limited
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    3
    England
    06 apr 2016
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    3
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006 (England)
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies In England And Wales
    Numero di registrazione02578864
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TRAMSCOM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 20 lug 2012
    Consegnato il 04 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £9,106.25 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    An account set up pursuant to a rent deposit deed in the sum of £9,106.25 supplemental to a lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Metropolitan Properties (Provincial) Limited
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 giu 2002
    Consegnato il 20 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    £19,500.00 and all other sums due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The interest of the company in the deposit account (£19,500).
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 20 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 07 nov 2001
    Consegnato il 10 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,000 and all other monies due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the account pursuant to the deed between the company (as tenant) and the chargee (as landlord) in which the deposit of £6,000 is placed.
    Persone aventi diritto
    • Metropolitan Property (Provincial) Limited
    Transazioni
    • 10 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cancom It Systeme Ag
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 ago 1997
    Consegnato il 03 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 29 nov 1996
    Consegnato il 14 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease of even date
    Brevi particolari
    All monies deposited in the rent deposit account pursuant to the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Olivetti UK Limited
    Transazioni
    • 14 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0