THE WINE STUDIO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE WINE STUDIO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02867477 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE WINE STUDIO LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova THE WINE STUDIO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Whitchurch Lane BS14 0JZ Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE WINE STUDIO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SAMUEL DOW LIMITED | 10 dic 1993 | 10 dic 1993 |
| TRUSHELFCO (NO. 1962) LIMITED | 01 nov 1993 | 01 nov 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE WINE STUDIO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE WINE STUDIO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2021 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per C&C Management Services Limited il 24 mar 2021 | 1 pagine | CH04 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2019 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan Solesbury come amministratore in data 14 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Ms Riona Heffernan come amministratore in data 14 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Andrea Pozzi come amministratore in data 14 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 27 apr 2019 al 28 feb 2019 | 1 pagine | AA01 | ||
Cessazione della carica di David George Johnston come amministratore in data 29 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di C&C Management Services Limited come segretario in data 26 set 2018 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di C&C Management Services (Uk) Limited come segretario in data 26 set 2018 | 1 pagine | TM02 | ||
Modifica dei dettagli di Matthew Clark (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 03 mag 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||
Nomina di Mr David Johnston come amministratore in data 17 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Jonathan Solesbury come amministratore in data 17 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Stephen Frederick Jebson come amministratore in data 17 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Mark Riley come amministratore in data 17 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di THE WINE STUDIO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&C MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario | Keeper Road Crumlin Bulmers House Dublin 12, D12 K702 Ireland |
| 172928540001 | ||||||||||||||
| HEFFERNAN, Riona | Amministratore | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | Ireland | Irish | 203083000001 | |||||||||||||
| ROBERTSON, Ewan James | Amministratore | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | Scotland | British | 208215190001 | |||||||||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Segretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||||||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Segretario | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | British | 69554640002 | ||||||||||||||
| PHILLIPS, David John | Segretario | BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane United Kingdom | 158113210001 | |||||||||||||||
| C&C MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED | Segretario | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3LH Exeter Ashford House England |
| 245149380001 | ||||||||||||||
| TRUSEC LIMITED | Segretario nominato | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||||||||||
| AYLWIN, Mark Terence | Amministratore | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | England | British | 105140040001 | |||||||||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||||||||||
| CHANDLER, Christine Anne | Amministratore delegato nominato | 31 Chesnut Grove New Malden Surrey | British | 900007180001 | ||||||||||||||
| CHRISTENSEN, Troy | Amministratore | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | American | 130789730003 | |||||||||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Amministratore | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | 28396500005 | |||||||||||||
| CREIGHTON, Thomas Hugh | Amministratore | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | 157727790001 | |||||||||||||
| DANDO, Stephen Peter | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||||||||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Amministratore | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||||||||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Amministratore | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137615160001 | |||||||||||||
| GRISMAN, Martin Gerald | Amministratore | Whitchurch Lane Whitchurch BS14 0JZ Bristol - Avon United Kingdom | England | British | 69428030002 | |||||||||||||
| HODGES, Nigel Ian | Amministratore | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | 75692570001 | ||||||||||||||
| HUMPHREYS, Andrew | Amministratore | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | England | British | 200489460001 | |||||||||||||
| HUNTER, Diana | Amministratore | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | England | British | 170154190002 | |||||||||||||
| HUNTER, Diana | Amministratore | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | England | British | 170154190002 | |||||||||||||
| JEBSON, Stephen Frederick | Amministratore | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | England | British | 171865850001 | |||||||||||||
| JOHNSTON, David George | Amministratore | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | Ireland | Irish | 198738340001 | |||||||||||||
| KLEIN, David | Amministratore | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | 119928070001 | ||||||||||||||
| LOUSADA, James David | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | 152222000001 | |||||||||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Amministratore | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 69554640002 | |||||||||||||
| MORAMARCO, Jon | Amministratore | C8 Trinity Gate Epsom Road GU1 3PW Guildford Surrey | American | 114902210001 | ||||||||||||||
| MORAN, Mark | Amministratore | Crewe CW1 6BP Cheshire Weston Road United Kingdom | United Kingdom | British | 60066000008 | |||||||||||||
| PETERS, Richard David | Amministratore | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 60630980002 | |||||||||||||
| POZZI, Andrea | Amministratore | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | Scotland | Italian | 195181530001 | |||||||||||||
| REEVE, Robert Arthur | Amministratore delegato nominato | 6 Wellesford Close SM7 2HL Banstead Surrey | British | 900007190001 | ||||||||||||||
| RILEY, Mark | Amministratore | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | England | British | 245151070001 | |||||||||||||
| SCHAAFSMA, Paul Michael | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 105189170004 | |||||||||||||
| SMITH, Andrew Peter | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | 175517180001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE WINE STUDIO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Clark Bibendum (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | Whitchurch BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE WINE STUDIO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 08 lug 2016 Consegnato il 22 lug 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 08 lug 2016 Consegnato il 21 lug 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 09 ott 2015 Consegnato il 16 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 09 ott 2015 Consegnato il 15 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 09 ott 2015 Consegnato il 15 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 17 apr 2007 Consegnato il 23 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts etc, insurances, other contracts, intellectual property, goodwill and floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0