GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED

GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02870260
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Stagecoach Services Ltd
    Daw Bank
    SK3 0DU Stockport
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STEEPLEMERE LIMITED09 nov 199309 nov 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 giu 2013

    Stato del capitale al 04 giu 2013

    • Capitale: GBP 4,069,608
    SH01

    Cessazione della carica di Leslie Brian Warneford come amministratore in data 26 apr 2013

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 feb 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    5 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 07 feb 2013

    • Capitale: GBP 4,069,608
    5 pagineSH02

    Cessazione della carica di Christopher John Bowles come amministratore in data 13 dic 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 apr 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Mr. Christopher John Bowles come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Arnold Threapleton come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Arnold Mark Threapleton il 11 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 10 ott 2009

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Leslie Brian Warneford il 01 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Colin Brown il 15 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 07 ott 2009

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    GRIFFITHS, Ross Gilmore
    53 Hazelwood Road
    SK9 2QA Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    53 Hazelwood Road
    SK9 2QA Wilmslow
    Cheshire
    British55789560001
    HASTINGS, Deneze Ann
    4 Kingsley Avenue
    Whitfield
    Manchester
    M45 8ha
    Segretario
    4 Kingsley Avenue
    Whitfield
    Manchester
    M45 8ha
    British37183230001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BICKLEY, Stephen Arthur
    19 Dunlin Close
    Offerton
    SK2 5UF Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    19 Dunlin Close
    Offerton
    SK2 5UF Stockport
    Cheshire
    British38672300001
    BOWLES, Christopher John, Mr.
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113853370001
    BOWLES, Christopher
    6 Stile Close
    Urmston
    M41 5TU Manchester
    Amministratore
    6 Stile Close
    Urmston
    M41 5TU Manchester
    British62587570001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COLSON, Benjamin
    Royal Retiring Rooms
    Wolferton
    PE31 6HA Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    Royal Retiring Rooms
    Wolferton
    PE31 6HA Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandBritish105923180001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    CULLIE, Edward Joseph
    61 Parkway
    Cheadle Heath
    SK3 0QH Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    61 Parkway
    Cheadle Heath
    SK3 0QH Stockport
    Cheshire
    British40626620001
    FITZPATRICK, Patrick Joseph
    10 Broadhill Road
    SK15 1HQ Stalybridge
    Cheshire
    Amministratore
    10 Broadhill Road
    SK15 1HQ Stalybridge
    Cheshire
    British40626680001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    GRIFFIES, Arthur Gary
    17 Princess Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 5ND Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    17 Princess Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 5ND Cheadle
    Cheshire
    British40626690001
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    GRIFFITHS, Ross Gilmore
    53 Hazelwood Road
    SK9 2QA Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    53 Hazelwood Road
    SK9 2QA Wilmslow
    Cheshire
    British55789560001
    HALSKI, Ziggy Rhys
    21 Eastleigh Road
    Heald Green
    SK8 3QR Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    21 Eastleigh Road
    Heald Green
    SK8 3QR Cheadle
    Cheshire
    British38586120001
    HALSKI, Ziggy Rhys
    21 Eastleigh Road
    Heald Green
    SK8 3QR Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    21 Eastleigh Road
    Heald Green
    SK8 3QR Cheadle
    Cheshire
    British38586120001
    HARVEY, Kenneth George
    Pine View Beechfield Road
    SK9 7EF Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Pine View Beechfield Road
    SK9 7EF Alderley Edge
    Cheshire
    British51923300002
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Amministratore
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    LLEWELLYN, Frank Henry
    22 Broadfield Grove
    North Reddish
    SK5 6XN Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    22 Broadfield Grove
    North Reddish
    SK5 6XN Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish38672050001
    MONTGOMERY, Robert
    Doublenuts
    Clowbridge
    BB11 5NX Burnley
    Amministratore
    Doublenuts
    Clowbridge
    BB11 5NX Burnley
    British57748800001
    MORAN, John
    16 Winnington Road
    Marple
    SK6 6PD Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    16 Winnington Road
    Marple
    SK6 6PD Stockport
    Cheshire
    British25466160001
    PYSDEN, Edward Scott
    London Scottish House 24
    Mount Street
    M2 3DB Manchester
    Amministratore
    London Scottish House 24
    Mount Street
    M2 3DB Manchester
    British59426050002
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish73518280001
    ROE, Darren John
    69 Riverholme View
    Brockmoles
    MD9 7BP Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    69 Riverholme View
    Brockmoles
    MD9 7BP Huddersfield
    West Yorkshire
    British78856020001
    SHORT, Peter
    2 Netherwood Road
    Northenden
    M22 4BQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    2 Netherwood Road
    Northenden
    M22 4BQ Manchester
    Lancashire
    British38223540001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    SUMNER, Peter
    15 The Shearers
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    15 The Shearers
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish53484340002
    TASKER, Elisabeth
    32 Sandy Lane
    WA13 9HQ Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    32 Sandy Lane
    WA13 9HQ Lymm
    Cheshire
    British71606010002
    THREAPLETON, Arnold Mark
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish84933000001

    GM BUSES SOUTH HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 10 gen 1997
    Consegnato il 18 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and security trustee for and on behalf of the banks, the issuing bank and the overdraft bank (all as therein defined) (or any of them) under the charge and under the agreement being the facility agreement dated 28 january 1996 (as therein defined) and under any of the other finance documents (as therein defined) and/or any deed or document supplemental thereto and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge all its and rights present and future. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 mar 1994
    Consegnato il 14 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a credit facility agreement dated 31ST march 1994 and any deed supplemental thereto
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tameside Metropolitan Borough Council(As Adminstrating Authority of Greater Manchester Pension Fund)
    Transazioni
    • 14 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1994
    Consegnato il 07 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0