BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED

BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02870913
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Arlington House
    Arlington Business Park
    RG7 4SA Theale
    Reading
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROXYPORT LIMITED10 nov 199310 nov 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 12 apr 2013

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 17 dic 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 18 dic 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Robert Paul Reed come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel Pope come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANCOSEC LIMITED
    Arlington House
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Segretario
    Arlington House
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    111724450001
    CORNELL, James Martin
    Hitchwood Lane
    SG4 7RW Preston
    Hitchwood Barn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hitchwood Lane
    SG4 7RW Preston
    Hitchwood Barn
    Hertfordshire
    EnglandBritishTreasurer148803950001
    REED, Robert Paul
    Arlington House
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4SA Reading
    Arlington House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Arlington House
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4SA Reading
    Arlington House
    Berkshire
    England
    EnglandBritishDirector Of Finance And Reporting148032280006
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Segretario
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    British49654480002
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishCompany Director10297860001
    LYNE, Sarah Jane
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    Segretario
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    British49635520003
    READ, Jonathan David
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    Segretario
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    British77460610002
    C & M SECRETARIES LIMITED
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    Segretario nominato
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    900007640001
    AUSTEN, Jonathan Martin
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51921200001
    BUSHNELL, Patrick James
    Pounce Hall
    Sewards End
    CB10 2LE Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Pounce Hall
    Sewards End
    CB10 2LE Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishInvestment Manager26791960001
    CHATER, Beth Salena
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant60464290003
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishBuilding Surveyor37099910001
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor49654480002
    ELLIOTT, Joanne Lesley
    50a Digby Mansions
    Hammersmith Bridge Road
    W6 9DF London
    Amministratore
    50a Digby Mansions
    Hammersmith Bridge Road
    W6 9DF London
    United KingdomBritishCorporate Finance Manager34738280002
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director10297860001
    HOPE, Philip Barrie
    3 Priory Terrace
    PE19 2BH St Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    3 Priory Terrace
    PE19 2BH St Neots
    Cambridgeshire
    BritishChartered Accountant46561960001
    JAGO, Christian Rachel Mary
    13 Kingslee Court
    Worcester Road
    SM2 6PH Sutton
    Surrey
    Amministratore
    13 Kingslee Court
    Worcester Road
    SM2 6PH Sutton
    Surrey
    BritishAccountant37810170001
    JOHNSTON, Andrew James
    Langford
    GL7 3LF Nr Lechlade
    Langford Grange
    Gloucestershire
    Amministratore
    Langford
    GL7 3LF Nr Lechlade
    Langford Grange
    Gloucestershire
    United KingdomBritishChartered Surveyor131001620001
    KINGON, Neil Bernard
    Green Pastures Bullocks Farm Lane
    Wheeler End
    HP14 3NQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Green Pastures Bullocks Farm Lane
    Wheeler End
    HP14 3NQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishAccountant4704070001
    MOHANLAL, Satish
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    Amministratore
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    BritishFinance Director51579180001
    MUDIE, Jeremy David
    Dean Cottage
    HP14 4NL Upper North Dean
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Dean Cottage
    HP14 4NL Upper North Dean
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor37432590001
    POPE, Nigel Howard
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    Amministratore
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant29583660002
    PULSFORD, Jeffrey Mark
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant49776690004
    SHEPPARD, Colin George
    Moffatt Cottage
    Berry Lane
    WD3 5EU Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Moffatt Cottage
    Berry Lane
    WD3 5EU Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor213673820001
    UNDERHILL, Anthony Owen
    10 Burghley Close
    MK45 1TF Flitwick
    Bedfordshire
    Amministratore
    10 Burghley Close
    MK45 1TF Flitwick
    Bedfordshire
    BritishFund Manager80855550001
    WHALLEY, Malcolm John
    19 Peartree Lane
    Wapping
    E1 9SR London
    Amministratore
    19 Peartree Lane
    Wapping
    E1 9SR London
    BritishDirector Of Property Investmen6718240002
    C & M REGISTRARS LIMITED
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    Amministratore delegato nominato
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    900007630001

    BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 04 mag 1999
    Consegnato il 05 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations of the company due to the chargee under a loan agreement dated 4 may 1999
    Brevi particolari
    L/H plots 6100 and 6200 birmingham business park solihull parkway t/n-WM626482.
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 05 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 feb 1999
    Consegnato il 22 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations of birmingham business park (joint venture) limited to the chargee under a loan agreement dated 18 february 1999
    Brevi particolari
    The leasehold property known as plot 2900 birmingham business park solihull parkway title number wm 626482.
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance Public Limited
    Transazioni
    • 22 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1998
    Consegnato il 20 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations due or to become due from birmingham business park (joint venture) limited to the chargee under a loan agreement dated 17TH april 1998
    Brevi particolari
    L/H land phase 1 unit 6100 birmingham business park solihull parkway t/no: WM626482.
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 20 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1998
    Consegnato il 09 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations of birmingham business park (joint venture) limited to the chargee under a loan agreement dated 10TH december 1997
    Brevi particolari
    L/H land unit 2300 (to be k/a compton house) birmingham business park solihull parkway t/n WM626482 (part).
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 09 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company ("covenantor") to the chargee under the loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Units 3010 and 3020 birmingham business park solihull parkway part t/n WM626482 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 gen 1997
    Consegnato il 30 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the covenantor (as defined) to the chargee under the loan agreement of even date
    Brevi particolari
    2620, 2625, 2630, 2635, 2640 and 2650 birmingham business park, solihull parkway t/no: WM626482 (part).
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 30 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1996
    Consegnato il 31 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The balance of the purchase price and other amounts which may become payable by the company and/or birmingham business park (trustee) limited to the chargee pursuant to an agreement for sale of the charged property dated 23 december 1996(as at 23 december 1996 £13,287.000 remained outstanding and repayable as to £6,644,000 on 19 december 1997 and £6,643,000 on 18 december 1998 subject to any payments made by the company prior to these repayment dates)
    Brevi particolari
    Plots 500 55000 and 6500 birmingham business park solihull parkway birmingham.t/no.WM544020.
    Persone aventi diritto
    • Bg Public Limited Company (Formerly British Gas Public Limited Company)
    Transazioni
    • 31 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 15 feb 1996
    Consegnato il 29 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from birmingham business park (joint venture) limited as general partner and on behalf of bbp partnership (a limited partnership) to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Units 2660, 2670, 2675 and 2680 birmingham business park t/n wm 586691. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance PLC
    Transazioni
    • 29 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facility terms (as defined)
    Brevi particolari
    All the land and buildings at birmingham business park bickenhill west midlands. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0