BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED
Panoramica
Nome della società | BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02870913 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Arlington House Arlington Business Park RG7 4SA Theale Reading |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ROXYPORT LIMITED | 10 nov 1993 | 10 nov 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 12 apr 2013
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 17 dic 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 18 dic 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Paul Reed come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Pope come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCOSEC LIMITED | Segretario | Arlington House Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 111724450001 | |||||||
CORNELL, James Martin | Amministratore | Hitchwood Lane SG4 7RW Preston Hitchwood Barn Hertfordshire | England | British | Treasurer | 148803950001 | ||||
REED, Robert Paul | Amministratore | Arlington House Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading Arlington House Berkshire England | England | British | Director Of Finance And Reporting | 148032280006 | ||||
DUFFIELD, David Mark Johnston | Segretario | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | British | 49654480002 | ||||||
FERGUSON, Iain Donald | Segretario | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | British | Company Director | 10297860001 | |||||
LYNE, Sarah Jane | Segretario | 11 Abelia Close West End GU24 9PG Woking Surrey | British | 49635520003 | ||||||
READ, Jonathan David | Segretario | 179 Tanworth Lane Shirley B90 4BZ Solihull West Midlands | British | 77460610002 | ||||||
C & M SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | PO BOX 55 7 Spa Road SE16 3QP London | 900007640001 | |||||||
AUSTEN, Jonathan Martin | Amministratore | Lygon Croft Sandy Way KT11 2EY Cobham Surrey | United Kingdom | British | Director | 51921200001 | ||||
BUSHNELL, Patrick James | Amministratore | Pounce Hall Sewards End CB10 2LE Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | Investment Manager | 26791960001 | ||||
CHATER, Beth Salena | Amministratore | Langham Lodge Bucklebury Alley RG18 9NH Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 60464290003 | ||||
DEIGMAN, Patrick | Amministratore | Frith Hill House Frith Hill HP16 0QR Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | Building Surveyor | 37099910001 | ||||
DUFFIELD, David Mark Johnston | Amministratore | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | England | British | Solicitor | 49654480002 | ||||
ELLIOTT, Joanne Lesley | Amministratore | 50a Digby Mansions Hammersmith Bridge Road W6 9DF London | United Kingdom | British | Corporate Finance Manager | 34738280002 | ||||
FERGUSON, Iain Donald | Amministratore | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 10297860001 | ||||
HOPE, Philip Barrie | Amministratore | 3 Priory Terrace PE19 2BH St Neots Cambridgeshire | British | Chartered Accountant | 46561960001 | |||||
JAGO, Christian Rachel Mary | Amministratore | 13 Kingslee Court Worcester Road SM2 6PH Sutton Surrey | British | Accountant | 37810170001 | |||||
JOHNSTON, Andrew James | Amministratore | Langford GL7 3LF Nr Lechlade Langford Grange Gloucestershire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 131001620001 | ||||
KINGON, Neil Bernard | Amministratore | Green Pastures Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Buckinghamshire | British | Accountant | 4704070001 | |||||
MOHANLAL, Satish | Amministratore | 21 Mostyn Gardens NW10 5QU London | British | Finance Director | 51579180001 | |||||
MUDIE, Jeremy David | Amministratore | Dean Cottage HP14 4NL Upper North Dean Buckinghamshire | England | British | Chartered Surveyor | 37432590001 | ||||
POPE, Nigel Howard | Amministratore | Hawthorne Road BR1 2HN Bromley 17 Kent | England | British | Chartered Accountant | 29583660002 | ||||
PULSFORD, Jeffrey Mark | Amministratore | Denesfield 16 Lytton Park KT11 2HB Cobham Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 49776690004 | ||||
SHEPPARD, Colin George | Amministratore | Moffatt Cottage Berry Lane WD3 5EU Chorleywood Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 213673820001 | ||||
UNDERHILL, Anthony Owen | Amministratore | 10 Burghley Close MK45 1TF Flitwick Bedfordshire | British | Fund Manager | 80855550001 | |||||
WHALLEY, Malcolm John | Amministratore | 19 Peartree Lane Wapping E1 9SR London | British | Director Of Property Investmen | 6718240002 | |||||
C & M REGISTRARS LIMITED | Amministratore delegato nominato | PO BOX 55 7 Spa Road SE16 3QP London | 900007630001 |
BIRMINGHAM BUSINESS PARK (JOINT VENTURE) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 04 mag 1999 Consegnato il 05 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the obligations of the company due to the chargee under a loan agreement dated 4 may 1999 | |
Brevi particolari L/H plots 6100 and 6200 birmingham business park solihull parkway t/n-WM626482. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 feb 1999 Consegnato il 22 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the obligations of birmingham business park (joint venture) limited to the chargee under a loan agreement dated 18 february 1999 | |
Brevi particolari The leasehold property known as plot 2900 birmingham business park solihull parkway title number wm 626482. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 apr 1998 Consegnato il 20 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the obligations due or to become due from birmingham business park (joint venture) limited to the chargee under a loan agreement dated 17TH april 1998 | |
Brevi particolari L/H land phase 1 unit 6100 birmingham business park solihull parkway t/no: WM626482. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 08 apr 1998 Consegnato il 09 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the obligations of birmingham business park (joint venture) limited to the chargee under a loan agreement dated 10TH december 1997 | |
Brevi particolari L/H land unit 2300 (to be k/a compton house) birmingham business park solihull parkway t/n WM626482 (part). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 mar 1997 Consegnato il 12 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company ("covenantor") to the chargee under the loan agreement of even date | |
Brevi particolari Units 3010 and 3020 birmingham business park solihull parkway part t/n WM626482 and the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 gen 1997 Consegnato il 30 gen 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the covenantor (as defined) to the chargee under the loan agreement of even date | |
Brevi particolari 2620, 2625, 2630, 2635, 2640 and 2650 birmingham business park, solihull parkway t/no: WM626482 (part). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 23 dic 1996 Consegnato il 31 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The balance of the purchase price and other amounts which may become payable by the company and/or birmingham business park (trustee) limited to the chargee pursuant to an agreement for sale of the charged property dated 23 december 1996(as at 23 december 1996 £13,287.000 remained outstanding and repayable as to £6,644,000 on 19 december 1997 and £6,643,000 on 18 december 1998 subject to any payments made by the company prior to these repayment dates) | |
Brevi particolari Plots 500 55000 and 6500 birmingham business park solihull parkway birmingham.t/no.WM544020. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 feb 1996 Consegnato il 29 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from birmingham business park (joint venture) limited as general partner and on behalf of bbp partnership (a limited partnership) to the chargee under the terms of a loan agreement of even date | |
Brevi particolari Units 2660, 2670, 2675 and 2680 birmingham business park t/n wm 586691. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 22 dic 1993 Consegnato il 12 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facility terms (as defined) | |
Brevi particolari All the land and buildings at birmingham business park bickenhill west midlands. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0