BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED

BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02873670
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    • fabbricazione di profumi e preparati per toletta (20420) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Kings Court Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAMPSHIRE COSMETICS LIMITED27 ott 199427 ott 1994
    RIDGEROW LIMITED19 nov 199319 nov 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Wystan Corporate Services Limited come amministratore in data 26 set 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Wystan Holdings Inc come amministratore in data 26 set 2018

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    49 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Decisions and resolutions ratified and approved 22/08/2018
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Wystan Holdings Inc come amministratore in data 22 ago 2018

    2 pagineAP02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 nov 2015

    Stato del capitale al 20 nov 2015

    • Capitale: GBP 1,650,200
    SH01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    AA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 dic 2014

    Stato del capitale al 05 dic 2014

    • Capitale: GBP 1,650,200
    SH01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    1 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 15 gen 2014

    • Capitale: GBP 200
    4 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1914417
    38915800008
    SMITH, Adrian Holmes
    St Ives Park
    BN24 2JX Ringwood
    57
    Hampshire
    Amministratore
    St Ives Park
    BN24 2JX Ringwood
    57
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant51302090001
    BLAND, Michael James
    Apartado 3531
    8135 Almancil
    Portugal
    Segretario
    Apartado 3531
    8135 Almancil
    Portugal
    British94686660002
    SANDERS, Robert Braith Charles
    Waterberry Drive
    PO7 7YW Waterlooville
    Brambles House
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Waterberry Drive
    PO7 7YW Waterlooville
    Brambles House
    Hampshire
    United Kingdom
    149449750001
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    Segretario
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    BritishCompany Secretary38965710001
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1914417
    38915800008
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Segretario nominato
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001990001
    DARKE, Charles Peter
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishDirector61772430003
    HARDY, Audrey Sylvia
    4201 Kean Road
    33314 Port Lauderdale
    Florida
    Amministratore
    4201 Kean Road
    33314 Port Lauderdale
    Florida
    BritishDirector39006670002
    HAYWOOD, Julia Louise
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishDirector160954760001
    JORDAN, Nicola
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector160951730001
    POLDING, Mark
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector160951850001
    SANDERS, Robert Braith Charles
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector70944840001
    SPERRING, Mark Anthony
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector160951960001
    VINE, David Graham
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector160952040001
    WAITE, Thomas Edward
    4201 Kean Road
    33314 Fort Lauderdale
    Florida
    Usa
    Amministratore
    4201 Kean Road
    33314 Fort Lauderdale
    Florida
    Usa
    BritishDirector39006760002
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    BritishCompany Secretary38965710001
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    BritishDirector38965710001
    YOUNGER, Paul Owen
    Church Road
    Newtown
    PO17 6LA Fareham
    The Grange
    Hampshire
    Amministratore
    Church Road
    Newtown
    PO17 6LA Fareham
    The Grange
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director6788640001
    ALDEBURGH ENTERPRISES LIMITED
    Suite 2a Eurolife Building
    1 Corral Road
    FOREIGN Gibraltar
    Amministratore
    Suite 2a Eurolife Building
    1 Corral Road
    FOREIGN Gibraltar
    46113110001
    BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore delegato nominato
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001980001
    C L CLEMO & CO CORPORATE SERVICES LIMITED
    88 Copse Hill
    Wimbledon Common
    SW20 0EF London
    Amministratore
    88 Copse Hill
    Wimbledon Common
    SW20 0EF London
    42479600001
    NEW CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    P.O. Box 146 Roadtown
    Tortola
    FOREIGN British Virgin Islands
    Amministratore
    P.O. Box 146 Roadtown
    Tortola
    FOREIGN British Virgin Islands
    48067050001
    WYSTAN CORPORATE SERVICES LIMITED
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Turks And Caicos Islands
    Amministratore
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Turks And Caicos Islands
    Forma giuridicaEXEMPTED COMPANY
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleTHE COMPANIES ORDANCE 1981
    Numero di registrazioneE39405
    174566920001
    WYSTAN CORPORATE SERVICES LIMITED
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Bwi
    Turks & Caicos Islan
    Amministratore
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Bwi
    Turks & Caicos Islan
    Forma giuridicaEXEMPTED COMPANY
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleTHE COMPANIES ORDINANCE 1981
    Numero di registrazioneE.39405
    145995950001
    WYSTAN HOLDINGS INC
    Leeward Highway
    Providenciales
    PO BOX 267, Bcm Cape Building
    Turks And Caicos Islands
    Amministratore
    Leeward Highway
    Providenciales
    PO BOX 267, Bcm Cape Building
    Turks And Caicos Islands
    Forma giuridicaCORPORATE
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleTURKS AND CAICOS ISLANDS
    Numero di registrazione29228
    249686940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06237275
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattels mortgage
    Creato il 19 ago 2011
    Consegnato il 20 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Asset name vibratory bowl feeder (model avb 460F) serial number AS496. Sleevit sleevemaster serial number SM850. Beltorgue cup tighting machine mode bt-st serial J10-015.00.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD and Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 20 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Creato il 05 lug 2011
    Consegnato il 07 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 07 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal assignment
    Creato il 28 giu 2011
    Consegnato il 29 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 giu 2011
    Consegnato il 15 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 24 nov 2008
    Consegnato il 26 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 26 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 set 1996
    Consegnato il 10 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a loan agreement of even date or the mortgage debenture
    Brevi particolari
    L/H property k/a brambles house, waterberry drive, waterlooville hampshire t/no: HP414945 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hampshire Cosmetic Laboratories Limited
    Transazioni
    • 10 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 nov 1994
    Consegnato il 21 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 14 nov 1994
    Consegnato il 21 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/as brambles house waterberry drive waterlooville hampshire.t/no.HP414945 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0