SPEED 3969 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SPEED 3969 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02875140 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPEED 3969 LIMITED?
- Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova SPEED 3969 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED 156 Great Charles Street B3 3HN Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPEED 3969 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 29 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPEED 3969 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 22 pagine | LIQ13 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Hunton House Highbridge Estate Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1LX | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Hunton House Highbridge Estate Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1LX | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Lachlan Campbell come amministratore in data 13 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hunton House Highbridge Estate Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1LX a 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN in data 12 ott 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Joanne Clare Bennett come amministratore in data 01 mar 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Joanne Clare Bennett come segretario in data 01 mar 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew David Pellington come amministratore in data 28 feb 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew David Pellington come segretario in data 28 feb 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David Lachlan Campbell come amministratore in data 13 nov 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jinlong Wang come amministratore in data 05 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jinlong Wang il 10 lug 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 dic 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jinlong Wang il 13 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 25 gen 2018 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPEED 3969 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENNETT, Joanne Clare | Segretario | Great Charles Street B3 3HN Birmingham 156 | 280635410001 | |||||||
| BENNETT, Joanne Clare | Amministratore | Great Charles Street B3 3HN Birmingham 156 | England | British | 184759270001 | |||||
| BELLER, Stanley Sherwin | Segretario | 43 Portland Place W1N 3AG London | British | 47914640002 | ||||||
| FREEMAN, Jackie Doreen | Segretario | Highbridge Estate Oxford Road UB8 1LX Uxbridge Hunton House Middlesex | British | 157126120001 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Segretario | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HAWKSLEY, Anthony Thomas | Segretario | 74 Hazlewell Road Putney SW15 6UR London | British | 18661780001 | ||||||
| PELLINGTON, Andrew David | Segretario | Highbridge Estate Oxford Road UB8 1LX Uxbridge Hunton House Middlesex | 190283860001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| 'T HOOFT, Robert Adrian Graham | Amministratore | 91-93 Shuttleworth Road SW11 3DL London | United Kingdom | Dutch | 89287690001 | |||||
| CAMPBELL, David Lachlan | Amministratore | Great Charles Street B3 3HN Birmingham 156 | England | British | 58507320001 | |||||
| DALE, Manjit | Amministratore | 84 Highgate West Hill N6 6LU London | England | British | 69966070002 | |||||
| FREEMAN, Jackie Doreen | Amministratore | Highbridge Estate Oxford Road UB8 1LX Uxbridge Hunton House Middlesex | England | British | 157126120001 | |||||
| HAWKSLEY, Anthony Thomas | Amministratore | 74 Hazlewell Road Putney SW15 6UR London | British | 18661780001 | ||||||
| HEATH, Chris | Amministratore | 7 Barber Close RG10 0RZ Reading Berkshire | British | 109868920001 | ||||||
| HODGSON, Richard Paul | Amministratore | Highbridge Estate Oxford Road UB8 1LX Uxbridge Hunton House Middlesex | England | British | 205795940001 | |||||
| LUYCKX, Charles Francis | Amministratore | 12 Tonsley Street SW18 1BJ London | United Kingdom | Italian | 68802830001 | |||||
| PELLINGTON, Andrew David | Amministratore | Highbridge Estate Oxford Road UB8 1LX Uxbridge Hunton House Middlesex | United Kingdom | British | 191886610001 | |||||
| ROBERTSON, Stephen James | Amministratore | Clarendon House 2 Clarendon Close W2 2NS London | United Kingdom | British | 78505200003 | |||||
| SMYTH, Harvey John | Amministratore | Highbridge Estate Oxford Road UB8 1LX Uxbridge Hunton House Middlesex | United Kingdom | British | 74178000002 | |||||
| STEEDS, David William Howitt | Amministratore | 1 Littleworth Avenue KT10 9PB Esher Surrey | England | British | 37730950002 | |||||
| SYKES, David John | Amministratore | 93 Brambletye Park Road RH1 6EN Redhill Surrey | Uk | British | 108164570001 | |||||
| SYKES, David John | Amministratore | 93 Brambletye Park Road RH1 6EN Redhill Surrey | Uk | British | 108164570001 | |||||
| WANG, Jinlong | Amministratore | Highbridge Estate Oxford Road UB8 1LX Uxbridge Hunton House Middlesex United Kingdom | Hong Kong | American | 197805890005 | |||||
| WOOLFSON, Robert Melvyn | Amministratore | 32 Bentley Way HA7 3RP Stanmore Middlesex | British | 1053610001 | ||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPEED 3969 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizzaexpress (Restaurants) Limited | 06 apr 2016 | Highbridge Estate Oxford Road UB8 1LX Uxbridge Hunton House Middlesex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SPEED 3969 LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 25 gen 2017 | 25 gen 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
SPEED 3969 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Creato il 30 set 2003 Consegnato il 15 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the any group company or any share company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land k/a 153-155 high street harborne birmingham B17 9QE t/n WM450078, f/h land k/a 3 church street luton LU1 3JE t/n BD231759, f/h land k/a 18 high street slough SL1 7JT t/n BK325314. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 15 lug 2003 Consegnato il 26 lug 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land known as 153-155 high street, harborne, birmingham B17 9QE t/n WM450078, f/h land known as 3 church street, luton LU1 3JE t/n BD231759, f/h land known as 18 high street, slough SL1 7JT t/n BK325314 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 14 mar 2001 Consegnato il 20 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 ott 1994 Consegnato il 25 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £140,378.63 and all other monies due or to become due from the company tothe chargee under or pursuant to the novation deed and the legal charge | |
Brevi particolari All property demised by an underlease dated 16 july 1993 with all buildings erections fixtures fittings plant machinery and equipment. Floating charge over all undertaking property and assets.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 feb 1994 Consegnato il 01 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
SPEED 3969 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0