SPEED 3969 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPEED 3969 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02875140
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPEED 3969 LIMITED?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova SPEED 3969 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED
    156 Great Charles Street
    B3 3HN Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPEED 3969 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per SPEED 3969 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    22 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Hunton House Highbridge Estate Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1LX

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Hunton House Highbridge Estate Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1LX

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di David Lachlan Campbell come amministratore in data 13 ott 2021

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Hunton House Highbridge Estate Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1LX a 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN in data 12 ott 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 set 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di Mrs Joanne Clare Bennett come amministratore in data 01 mar 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Joanne Clare Bennett come segretario in data 01 mar 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew David Pellington come amministratore in data 28 feb 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew David Pellington come segretario in data 28 feb 2021

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2019

    7 pagineAA

    Nomina di Mr David Lachlan Campbell come amministratore in data 13 nov 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jinlong Wang come amministratore in data 05 nov 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jinlong Wang il 10 lug 2019

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Jinlong Wang il 13 lug 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 25 gen 2018

    2 paginePSC09

    Chi sono gli amministratori di SPEED 3969 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENNETT, Joanne Clare
    Great Charles Street
    B3 3HN Birmingham
    156
    Segretario
    Great Charles Street
    B3 3HN Birmingham
    156
    280635410001
    BENNETT, Joanne Clare
    Great Charles Street
    B3 3HN Birmingham
    156
    Amministratore
    Great Charles Street
    B3 3HN Birmingham
    156
    EnglandBritish184759270001
    BELLER, Stanley Sherwin
    43 Portland Place
    W1N 3AG London
    Segretario
    43 Portland Place
    W1N 3AG London
    British47914640002
    FREEMAN, Jackie Doreen
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    Segretario
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    British157126120001
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Segretario
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HAWKSLEY, Anthony Thomas
    74 Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    Segretario
    74 Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    British18661780001
    PELLINGTON, Andrew David
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    Segretario
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    190283860001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    'T HOOFT, Robert Adrian Graham
    91-93 Shuttleworth Road
    SW11 3DL London
    Amministratore
    91-93 Shuttleworth Road
    SW11 3DL London
    United KingdomDutch89287690001
    CAMPBELL, David Lachlan
    Great Charles Street
    B3 3HN Birmingham
    156
    Amministratore
    Great Charles Street
    B3 3HN Birmingham
    156
    EnglandBritish58507320001
    DALE, Manjit
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    Amministratore
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    EnglandBritish69966070002
    FREEMAN, Jackie Doreen
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    Amministratore
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    EnglandBritish157126120001
    HAWKSLEY, Anthony Thomas
    74 Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    Amministratore
    74 Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    British18661780001
    HEATH, Chris
    7 Barber Close
    RG10 0RZ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    7 Barber Close
    RG10 0RZ Reading
    Berkshire
    British109868920001
    HODGSON, Richard Paul
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    Amministratore
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    EnglandBritish205795940001
    LUYCKX, Charles Francis
    12 Tonsley Street
    SW18 1BJ London
    Amministratore
    12 Tonsley Street
    SW18 1BJ London
    United KingdomItalian68802830001
    PELLINGTON, Andrew David
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    Amministratore
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    United KingdomBritish191886610001
    ROBERTSON, Stephen James
    Clarendon House
    2 Clarendon Close
    W2 2NS London
    Amministratore
    Clarendon House
    2 Clarendon Close
    W2 2NS London
    United KingdomBritish78505200003
    SMYTH, Harvey John
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    Amministratore
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    United KingdomBritish74178000002
    STEEDS, David William Howitt
    1 Littleworth Avenue
    KT10 9PB Esher
    Surrey
    Amministratore
    1 Littleworth Avenue
    KT10 9PB Esher
    Surrey
    EnglandBritish37730950002
    SYKES, David John
    93 Brambletye Park Road
    RH1 6EN Redhill
    Surrey
    Amministratore
    93 Brambletye Park Road
    RH1 6EN Redhill
    Surrey
    UkBritish108164570001
    SYKES, David John
    93 Brambletye Park Road
    RH1 6EN Redhill
    Surrey
    Amministratore
    93 Brambletye Park Road
    RH1 6EN Redhill
    Surrey
    UkBritish108164570001
    WANG, Jinlong
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    United Kingdom
    Hong KongAmerican197805890005
    WOOLFSON, Robert Melvyn
    32 Bentley Way
    HA7 3RP Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    32 Bentley Way
    HA7 3RP Stanmore
    Middlesex
    British1053610001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SPEED 3969 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    England
    06 apr 2016
    Highbridge Estate
    Oxford Road
    UB8 1LX Uxbridge
    Hunton House
    Middlesex
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02805490
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SPEED 3969 LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    25 gen 201725 gen 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    SPEED 3969 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 30 set 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the any group company or any share company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a 153-155 high street harborne birmingham B17 9QE t/n WM450078, f/h land k/a 3 church street luton LU1 3JE t/n BD231759, f/h land k/a 18 high street slough SL1 7JT t/n BK325314. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 15 lug 2003
    Consegnato il 26 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land known as 153-155 high street, harborne, birmingham B17 9QE t/n WM450078, f/h land known as 3 church street, luton LU1 3JE t/n BD231759, f/h land known as 18 high street, slough SL1 7JT t/n BK325314 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 26 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 mar 2001
    Consegnato il 20 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 ott 1994
    Consegnato il 25 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £140,378.63 and all other monies due or to become due from the company tothe chargee under or pursuant to the novation deed and the legal charge
    Brevi particolari
    All property demised by an underlease dated 16 july 1993 with all buildings erections fixtures fittings plant machinery and equipment. Floating charge over all undertaking property and assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canary Wharf Limited
    Transazioni
    • 25 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 feb 1994
    Consegnato il 01 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aitken Hume Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SPEED 3969 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 set 2021Inizio della liquidazione
    19 gen 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Harvey Dean
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Praticante
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Stephen Roland Browne
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Praticante
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0