GARDENBOOK PROJECTS LIMITED

GARDENBOOK PROJECTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGARDENBOOK PROJECTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02875522
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GARDENBOOK PROJECTS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova GARDENBOOK PROJECTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Thorney Fen
    Rosslyn Lane
    CW8 2JZ Cuddington
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GARDENBOOK PROJECTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per GARDENBOOK PROJECTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 26 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 dic 2012

    Stato del capitale al 28 dic 2012

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 26 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Anthony John Norton il 30 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Howard Wyndham Bilton il 30 set 2011

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Indirizzo della sede legale modificato da North House 17 North John Street Liverpool Merseyside L2 5EA in data 06 set 2011

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Helen Silvano come segretario in data 26 ago 2011

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Robert Lovelady come segretario in data 26 ago 2011

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Robert Lovelady come amministratore in data 26 ago 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Barry Owen come amministratore in data 26 ago 2011

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2009 al 31 mar 2010

    3 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di GARDENBOOK PROJECTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BILTON, Howard Wyndham
    Summerhill Road
    Prestbury
    SK10 4AH Macclesfield
    Stone Cottage
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Summerhill Road
    Prestbury
    SK10 4AH Macclesfield
    Stone Cottage
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director141522310001
    NORTON, Anthony John
    Rosslyn Lane
    Cuddington
    CW8 2JZ Northwich
    Thorney Fen
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Rosslyn Lane
    Cuddington
    CW8 2JZ Northwich
    Thorney Fen
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director11914150003
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Segretario
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    BritishAccountant41693730006
    SILVANO, Helen
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    British55343270002
    WILKINSON, Christopher John
    46 Grange Road
    Bowdon
    WA14 3EY Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    46 Grange Road
    Bowdon
    WA14 3EY Altrincham
    Cheshire
    British90439130001
    WILLIAMS, Stephen Robert
    15 Charlesbye Avenue
    L39 2XY Ormskirk
    Lancashire
    Segretario
    15 Charlesbye Avenue
    L39 2XY Ormskirk
    Lancashire
    British911620001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, Ronald George
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    Amministratore
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    BritishCompany Director36193370001
    BILTON, Howard Wyndham
    Uplands Firs Lane
    Appleton
    WA4 5LD Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Uplands Firs Lane
    Appleton
    WA4 5LD Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director12490470001
    BILTON, Robert
    Park House
    Park Lane, Walton
    WA4 5LH Warrington
    Amministratore
    Park House
    Park Lane, Walton
    WA4 5LH Warrington
    EnglandBritishCompany Director63160400002
    BULLIVANT, Peter Wild
    State House 22 Dale Street
    L2 4UR Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    State House 22 Dale Street
    L2 4UR Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishSolicitor50290920001
    HOSKINSON, Philip Edward
    Thorlands
    Mill Hill Road
    CH61 4XA Wirral
    Wirral
    Amministratore
    Thorlands
    Mill Hill Road
    CH61 4XA Wirral
    Wirral
    BritishCompany Director69384790001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Amministratore
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritishAccountant41693730006
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Amministratore
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Surveyor69716360003
    WILLIAMS, Stephen Robert
    15 Charlesbye Avenue
    L39 2XY Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    15 Charlesbye Avenue
    L39 2XY Ormskirk
    Lancashire
    BritishFinancial Director911620001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GARDENBOOK PROJECTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge deed
    Creato il 09 gen 2004
    Consegnato il 17 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the f/h property 92-98 brighton road, purley t/no SGL596640, stocks shares and other securities.floating charge all plant machinery fixed charge the goodwill, the benefit of all licences, book debts, implements utensils vehicles goods and other equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge deed
    Creato il 31 ott 2000
    Consegnato il 09 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the f/h land at 62-66 boughton chester t/no.CH40222 and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery goodwill of any trade or business benefit of licences all book debts .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 09 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 set 2000
    Consegnato il 19 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £476,000 and other sums due from the company to ethel austin properties holdings limited under the terms of a facility letter of even date
    Brevi particolari
    92/98 brighton road purley.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Properties Holdings Limited
    Transazioni
    • 19 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge deed
    Creato il 04 nov 1998
    Consegnato il 06 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land being 411 to 419 (odd numbers) millbrook road southampton hampshire; f/h land being 130 to 138 (even numbers) holdenhurst road bournemouth; f/h land being filton central garage gloucester road north filton south gloucestershire t/nos: HP444379 DT148156 AV232128 and all buildings trade or other fixtures fixed plant and machinery from time to time thereon the goodwill of any trade or business; licences, bookdebts .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 06 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mag 1998
    Consegnato il 28 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement
    Brevi particolari
    All that land and buildings k/a central filling station gloucester road north filton bristol avon and an assignment of the benefit of all contracts deeds undertakings agreements rights warranties securities covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Investment Properties Limited
    Transazioni
    • 28 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 1998
    Consegnato il 01 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and facility agreement of even date
    Brevi particolari
    All and and buildings at tewkesbury road chelteham gloucester t/no;-GR198438 together with the benefit of all contracts deeds undertakings agreements rights warranties securities covenants guarantees bonds and indemnities held by the company related to the property and/or the development of the property benefit of all insurance policies and all rental monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Investment Properties Limited
    Transazioni
    • 01 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mar 1998
    Consegnato il 12 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement
    Brevi particolari
    All that land and buildings at 130/138 holderness road bournemouth.t/no.DT148156.by way of an assignment:the benefit of all contracts deeds undertakings agreements rights warranties securities covenants guarantees bonds and indemnities of any nature now or at any time enjoyed or held by the company and relating to the property and/or the development of the property;the benefit of all insurance policies and contracts of insurance relating to the property.the benefit of all rentals rents service charge charges and licence fees (if any) payable under or in respect of any lease underleases tenancy or agreement for lease affecting the property.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Investment Properties Limited
    Transazioni
    • 12 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 11 feb 1998
    Consegnato il 24 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement
    Brevi particolari
    Land and buildings at 411/419 (odd no's) millbrook road southampton hampshire t/no HP444379 with the benefit of all contracts warranties securities insurance policies rentals etc,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Investment Properties Limited
    Transazioni
    • 24 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 feb 1998
    Consegnato il 12 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement
    Brevi particolari
    All land and buildings lying to the south of boughton known as the dee service station boughton chester cheshire the benefot of all contracts deeds undertakings all insurance policies contracts of insurance rentals rents service charges. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Investment Properties Limited
    Transazioni
    • 12 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 21 ott 1996
    Consegnato il 29 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    501 cowbridge rd,west ealey,cardiff; t/no wa 699327 and 349 wellford rd,leicester LE2 6PG; t/no lt 20438 with all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery thereon; the benefit of licenses consents permissions and agreements.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 29 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 03 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 19 feb 1996
    Consegnato il 21 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at the rear of 97-107 main road gidea park romford t/no:- EGL340744 and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery from time to time thereon the goodwill of any business at the property the benefit of all present and future licences all bookdebts and monetary debts all stocks shares and other securities all estates and interests in any land now or hereafter belonging to the borrower and licences held for use of such land. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 21 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1996
    Consegnato il 13 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility agreement dated 5TH january 1996 and all other monies due under the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property situate at 501 cowbridge road west ely cardiff south glamorgan t/no. WA699327 and all buildings fixtures fittings plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Shop Properties Limited
    Transazioni
    • 13 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 14 dic 1995
    Consegnato il 18 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    6 fenwick road,giffnock,glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Bradford and Bingley Building Society
    Transazioni
    • 18 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 06 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land with buildings on north west side of queens drive nottingham k/a unit 1 riverside retails park t/n nt 294940; f/h land and buildings k/a 97-107 main road gidear park romford t/n egl 337307 and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 1995
    Consegnato il 06 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-97-107 main road gidea park romford essex.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Shop Properties Limited
    Transazioni
    • 06 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 giu 1995
    Consegnato il 16 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property at 349 welford rd,leicester; t/no.lt 20438.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Shop Properties Limited
    Transazioni
    • 16 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1994
    Consegnato il 18 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate at riverside retail park queens drive nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Shop Properties Limited
    Transazioni
    • 18 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland 21ST march 1994
    Creato il 21 mar 1994
    Consegnato il 30 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Ground and buildings at 6 fenwick road, giffnock, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Shop Properties Limited
    Transazioni
    • 30 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0