TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED

TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02876730
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    110 Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INTERNET RECRUITMENT GROUP LIMITED08 gen 199808 gen 1998
    INTERNET CONTRACT SERVICES LIMITED01 dic 199301 dic 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 ott 2017

    • Capitale: GBP 2
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of the share premium account 27/10/2017
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Harvey Nash Group Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Nomina di Mark Jonathan Garratt come amministratore in data 27 apr 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mark Jonathan Garratt come segretario in data 27 apr 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan Richard Ashcroft come amministratore in data 27 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Richard Ashcroft come segretario in data 27 apr 2017

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 gen 2016

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 lug 2016

    Stato del capitale al 04 lug 2016

    • Capitale: GBP 173,507.3
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 nov 2015

    Stato del capitale al 02 nov 2015

    • Capitale: GBP 173,507.3
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 dic 2014

    Stato del capitale al 24 dic 2014

    • Capitale: GBP 173,507.3
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2014

    16 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Harvey Nash Heron Tower 110 Bishopsgate London England and Wales EC2N 4AY a 110 Bishopsgate London EC2N 4AY in data 22 set 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 nov 2013

    Stato del capitale al 08 nov 2013

    • Capitale: GBP 173,507.3
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2013

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    231362320001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish49452080003
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    EnglandBritish229682100001
    WASSALL, Simon Mark
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    Amministratore
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    EnglandBritish108449780001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British258414370001
    BROADFOOT, Victoria Louise
    8 Aigburth Mansions
    Mowll Street Vauxhall
    SW9 0EP London
    Segretario
    8 Aigburth Mansions
    Mowll Street Vauxhall
    SW9 0EP London
    British56121450002
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Segretario
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British49452080003
    LINCOLN, Simon Paul
    94 Fentiman Road
    Vauxhall
    SW8 1LA London
    Segretario
    94 Fentiman Road
    Vauxhall
    SW8 1LA London
    British37131030001
    STEVENS, Paul John
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    Segretario
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    British36606580005
    WEST, Ashley Brendon George
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    British58376020002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish258414370001
    BEEKE, Paul Lincoln
    Apartment 9n
    New York
    Ny 10013
    U S A
    Amministratore
    Apartment 9n
    New York
    Ny 10013
    U S A
    British60439120004
    CRAWFORD, Thomas Francis Alexander
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    Amministratore
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    United KingdomBritish3856480002
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    British81663830001
    GOODMAN, Andrew Graham
    The Pound House
    46 Totteridge Village
    N20 8PR London
    Amministratore
    The Pound House
    46 Totteridge Village
    N20 8PR London
    United KingdomBritish57773080002
    HEATH, James Edward
    87 Langham Road
    TW11 9HG Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    87 Langham Road
    TW11 9HG Teddington
    Middlesex
    British1329740003
    HIGGINS, David Charles
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    Amministratore
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    United KingdomBritish33333910003
    STEVENS, Paul John
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    Amministratore
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    EnglandBritish36606580005
    TICE, Trevor Anthony
    1364 Union Street C
    San Francisco Ca 94109
    Usa
    Amministratore
    1364 Union Street C
    San Francisco Ca 94109
    Usa
    American61254610001
    WEST, Ashley Brendon George
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    British58376020002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3320790
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 giu 2002
    Consegnato il 13 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 24 mar 2000
    Consegnato il 31 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re techpartners international limited business premium account number 00453471 and barclays bank PLC re techpartners international limited barclays united states dollar deposit account number 49916766. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Creato il 16 nov 1998
    Consegnato il 25 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge over all debts purchased pursuant to the agreement with all related rights thereto and all amounts of indebtedness owing or becoming due to the company; floating charge over monies received in respect of the debts.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 apr 1994
    Consegnato il 13 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future and a floating charge on all book debts and other debts.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 13 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0