HUMBER OFFSHORE LIMITED

HUMBER OFFSHORE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUMBER OFFSHORE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02879946
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HUMBER OFFSHORE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HUMBER OFFSHORE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Global Shipping Services Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    DN41 8DY Stallingborough Grimsby
    North East Lincolnshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HUMBER OFFSHORE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HUMBER OFFSHORE SUPPLYLINK LIMITED11 feb 199411 feb 1994
    JENTRAY LIMITED13 dic 199313 dic 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUMBER OFFSHORE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per HUMBER OFFSHORE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Peter Robert Hickson come amministratore in data 12 giu 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Roger Thomas Leitch come amministratore in data 16 apr 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 dic 2015

    Stato del capitale al 18 dic 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2014

    Stato del capitale al 16 dic 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 13 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2013

    Stato del capitale al 17 dic 2013

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HUMBER OFFSHORE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JOBES, David Alan
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Segretario
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    British55316290002
    HICKSON, Peter Robert
    C/O Global Shipping Services Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    DN41 8DY Stallingborough Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    C/O Global Shipping Services Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    DN41 8DY Stallingborough Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish259446490001
    JOBES, David Alan
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish55316290002
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    British34404400001
    COCKERTON, Timothy
    12 Clixby Close
    DN35 0HS Cleethorpes
    South Humberside
    Segretario
    12 Clixby Close
    DN35 0HS Cleethorpes
    South Humberside
    British38630730001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Segretario nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    RYAN, Charles John
    Braxholme
    St Giles Croft
    HU17 8LD Beverley
    North Humberside
    Segretario
    Braxholme
    St Giles Croft
    HU17 8LD Beverley
    North Humberside
    British21697760001
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    British34404400001
    BOYD, James Adams
    Sleepers
    Station Road
    EH41 4QL Gifford
    East Lothian
    Amministratore
    Sleepers
    Station Road
    EH41 4QL Gifford
    East Lothian
    British39891810001
    COLLIE, Duncan Mclellen
    48 Irvine Place
    AB10 6HB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    48 Irvine Place
    AB10 6HB Aberdeen
    Aberdeenshire
    British64125270001
    DALY, Jeremy De Burgh
    62 Rubislaw Den South
    AB2 6AX Aberdeen
    Amministratore
    62 Rubislaw Den South
    AB2 6AX Aberdeen
    British30915850001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Amministratore delegato nominato
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EDWARDS, John Norman
    15 Hewson Road
    Humberston
    DN36 4UD Grimsby
    South Humberside
    Amministratore
    15 Hewson Road
    Humberston
    DN36 4UD Grimsby
    South Humberside
    British26537100001
    JOHNSON, Robin Stuart Craig
    Paylors Cottage
    Church View
    LS22 5JD Hunsingore
    Wetherey
    Amministratore
    Paylors Cottage
    Church View
    LS22 5JD Hunsingore
    Wetherey
    British46365320003
    JONES, Gordon
    57 Itterby Crescent
    DN35 9QJ Cleethorpes
    South Humberside
    Amministratore
    57 Itterby Crescent
    DN35 9QJ Cleethorpes
    South Humberside
    EnglandBritish62512760001
    LEITCH, Roger Thomas
    Beech House43 Main Street
    Saxby All Saints
    DN20 0QF Brigg
    South Humberside
    Amministratore
    Beech House43 Main Street
    Saxby All Saints
    DN20 0QF Brigg
    South Humberside
    EnglandBritish94573040001
    LLOYD, Christopher Paul
    6 Belvidere Crescent
    AB25 2NH Aberdeen
    Amministratore
    6 Belvidere Crescent
    AB25 2NH Aberdeen
    British50630320003
    MAITLAND, David Young
    8 Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peeblesshire
    Amministratore
    8 Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peeblesshire
    British64728520001
    MARPLES, Steven Trevor
    Dalmuinzie Lodge Dalmuinzie Road
    Bieldside
    AB15 9EB Aberdeen
    Amministratore
    Dalmuinzie Lodge Dalmuinzie Road
    Bieldside
    AB15 9EB Aberdeen
    British61206500001
    RYAN, Charles John
    Braxholme
    St Giles Croft
    HU17 8LD Beverley
    North Humberside
    Amministratore
    Braxholme
    St Giles Croft
    HU17 8LD Beverley
    North Humberside
    British21697760001
    STEWART, Neale John
    56 Braeside Place
    AB1 7TU Aberdeen
    Amministratore
    56 Braeside Place
    AB1 7TU Aberdeen
    British45429920001
    WATTERSON, Juan Patrick
    14 Pelham Place
    LS7 3QZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    14 Pelham Place
    LS7 3QZ Leeds
    West Yorkshire
    French/British36808640001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HUMBER OFFSHORE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Global Shipping Services Estates Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    Stallingborough
    DN41 8DY Grimsby
    Global Shipping Services Estates Ltd
    North East Lincolnshire
    England
    06 apr 2016
    Kiln Lane Trading Estate
    Stallingborough
    DN41 8DY Grimsby
    Global Shipping Services Estates Ltd
    North East Lincolnshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione916182
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HUMBER OFFSHORE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 10 ott 2011
    Consegnato il 11 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Omnibus guarantee & set-off agreement
    Creato il 03 gen 2006
    Consegnato il 05 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from or by any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its credit balance and all other money and liabilities.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH june 1997 and
    Creato il 04 lug 2002
    Consegnato il 12 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 lug 2002
    Consegnato il 12 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0