HUMBER OFFSHORE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HUMBER OFFSHORE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02879946 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HUMBER OFFSHORE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HUMBER OFFSHORE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Global Shipping Services Ltd Kiln Lane Trading Estate DN41 8DY Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HUMBER OFFSHORE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HUMBER OFFSHORE SUPPLYLINK LIMITED | 11 feb 1994 | 11 feb 1994 |
| JENTRAY LIMITED | 13 dic 1993 | 13 dic 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HUMBER OFFSHORE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per HUMBER OFFSHORE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Robert Hickson come amministratore in data 12 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Roger Thomas Leitch come amministratore in data 16 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HUMBER OFFSHORE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOBES, David Alan | Segretario | 26 The Avenue Healing DN41 7NE Grimsby North East Lincolnshire | British | 55316290002 | ||||||
| HICKSON, Peter Robert | Amministratore | C/O Global Shipping Services Ltd Kiln Lane Trading Estate DN41 8DY Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire | England | British | 259446490001 | |||||
| JOBES, David Alan | Amministratore | 26 The Avenue Healing DN41 7NE Grimsby North East Lincolnshire | England | British | 55316290002 | |||||
| BARKER, Jack | Segretario | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | 34404400001 | ||||||
| COCKERTON, Timothy | Segretario | 12 Clixby Close DN35 0HS Cleethorpes South Humberside | British | 38630730001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Segretario nominato | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| RYAN, Charles John | Segretario | Braxholme St Giles Croft HU17 8LD Beverley North Humberside | British | 21697760001 | ||||||
| BARKER, Jack | Amministratore | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | 34404400001 | ||||||
| BOYD, James Adams | Amministratore | Sleepers Station Road EH41 4QL Gifford East Lothian | British | 39891810001 | ||||||
| COLLIE, Duncan Mclellen | Amministratore | 48 Irvine Place AB10 6HB Aberdeen Aberdeenshire | British | 64125270001 | ||||||
| DALY, Jeremy De Burgh | Amministratore | 62 Rubislaw Den South AB2 6AX Aberdeen | British | 30915850001 | ||||||
| DOYLE, Betty June | Amministratore delegato nominato | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Amministratore delegato nominato | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| EDWARDS, John Norman | Amministratore | 15 Hewson Road Humberston DN36 4UD Grimsby South Humberside | British | 26537100001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Stuart Craig | Amministratore | Paylors Cottage Church View LS22 5JD Hunsingore Wetherey | British | 46365320003 | ||||||
| JONES, Gordon | Amministratore | 57 Itterby Crescent DN35 9QJ Cleethorpes South Humberside | England | British | 62512760001 | |||||
| LEITCH, Roger Thomas | Amministratore | Beech House43 Main Street Saxby All Saints DN20 0QF Brigg South Humberside | England | British | 94573040001 | |||||
| LLOYD, Christopher Paul | Amministratore | 6 Belvidere Crescent AB25 2NH Aberdeen | British | 50630320003 | ||||||
| MAITLAND, David Young | Amministratore | 8 Frankscroft EH45 9DX Peebles Peeblesshire | British | 64728520001 | ||||||
| MARPLES, Steven Trevor | Amministratore | Dalmuinzie Lodge Dalmuinzie Road Bieldside AB15 9EB Aberdeen | British | 61206500001 | ||||||
| RYAN, Charles John | Amministratore | Braxholme St Giles Croft HU17 8LD Beverley North Humberside | British | 21697760001 | ||||||
| STEWART, Neale John | Amministratore | 56 Braeside Place AB1 7TU Aberdeen | British | 45429920001 | ||||||
| WATTERSON, Juan Patrick | Amministratore | 14 Pelham Place LS7 3QZ Leeds West Yorkshire | French/British | 36808640001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HUMBER OFFSHORE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Shipping Services Estates Ltd | 06 apr 2016 | Kiln Lane Trading Estate Stallingborough DN41 8DY Grimsby Global Shipping Services Estates Ltd North East Lincolnshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HUMBER OFFSHORE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 10 ott 2011 Consegnato il 11 ott 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Omnibus guarantee & set-off agreement | Creato il 03 gen 2006 Consegnato il 05 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from or by any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Its credit balance and all other money and liabilities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH june 1997 and | Creato il 04 lug 2002 Consegnato il 12 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 lug 2002 Consegnato il 12 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0