CASTORS INTERNATIONAL LIMITED

CASTORS INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTORS INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02879952
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE CASTOR COMPANY LIMITED07 apr 199407 apr 1994
    LEBEN LIMITED13 dic 199313 dic 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagineLIQ14

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    13 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 gen 2020

    15 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:form LIQ12 - secretary of state's release
    3 pagineLIQ MISC

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    11 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 gen 2019

    22 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    31 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    1 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    9 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    39 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Colson Castors Ltd Bagnall Street Golds Hill West Bromwich West Midlands B70 0TS a 4 Hardman Square Spininningfields Manchester M3 3EB in data 16 gen 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Richard William White come amministratore in data 18 apr 2016

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 028799520006 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 feb 2016

    Stato del capitale al 22 feb 2016

    • Capitale: GBP 17,661,062.4
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2014

    29 pagineAA

    Cessazione della carica di John Hinds come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Derrick James Towell come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 feb 2015

    Stato del capitale al 27 feb 2015

    • Capitale: GBP 17,661,062.4
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 13 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2014

    Stato del capitale al 16 dic 2014

    • Capitale: GBP 17,661,062.4
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2013

    28 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CASTORS INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITHIES, John Andrew
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Segretario
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    190475840001
    BLASHILL, Thomas William
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United StatesAmerican181117260001
    SMITHIES, John Andrew
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish153425220003
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    BALDWIN, Robert Michael
    19 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Segretario
    19 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    English35556690001
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    British51615270002
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Segretario
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    British23060180001
    TOWELL, Derrick James
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    Segretario
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    British107375020001
    TUCKER, Louhon
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    Segretario
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    American98409710001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Segretario
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    British83233170002
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    BALDWIN, Robert Michael
    19 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    19 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    EnglandEnglish35556690001
    CHAHALIS, Scott Christian
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    UsaUnited States157829560001
    COWHIG, Timothy Joseph
    45 Carbery Avenue
    BH6 3LN Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    45 Carbery Avenue
    BH6 3LN Bournemouth
    Dorset
    British111232550001
    DAVIES, John Bernard
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    Amministratore
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    British2874530001
    DAVIES, John Roger
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    British29214160002
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish51615270002
    HINDS, John
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    UsaAmerican185679720001
    LILLY, Robert
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish97998580001
    LILLY, Robert
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritish97998580001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    British23060180001
    PRITZKER, Robert Alan
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    Amministratore
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    United StatesAmerican47230840001
    ROGERS, John Leonard
    The Old House
    The Square
    NN6 9SD Hannington
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Old House
    The Square
    NN6 9SD Hannington
    Northamptonshire
    United KingdomBritish19597130001
    SANKEY, David Baldwin
    Innage House
    TF11 9AB Shifnal
    Shropshire
    Amministratore
    Innage House
    TF11 9AB Shifnal
    Shropshire
    United KingdomBritish6346070001
    SHIPLEY, Robert
    The Cottage Chapel Lane
    Ombersley
    WR9 0DT Worcester
    Amministratore
    The Cottage Chapel Lane
    Ombersley
    WR9 0DT Worcester
    British43762210001
    SMITH, Christopher Joseph
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    UsaAmerican157830370001
    TOWELL, Derrick James
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish107375020001
    TUCKER, Louhon
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    United StatesAmerican98409710001
    VRESICS, John J
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    Amministratore
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    United StatesUsa152264500001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Amministratore
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    British83233170002
    WHITE, Richard William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish184103760001
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001

    CASTORS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 07 ago 2014
    Consegnato il 13 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of charge
    Creato il 03 ott 1995
    Consegnato il 07 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from global castors limited and/or british castors limited and/or J.B.D.plastics limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies at any time to the credit of any accounts in the books of the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 nov 1994
    Consegnato il 18 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment the keyman life assurance policy issued by general accident life assurance limited numbered 2679598LY on the life of john roger davies in the sum of £500,000 and all monies including bonuses benefits and other advantages which are payable or accrue thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 18 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 25 apr 1994
    Consegnato il 29 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from british castors limited and/or global castors limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies nor or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 apr 1994
    Consegnato il 03 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 03 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 22 apr 1994
    Consegnato il 28 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stone Investments (Number 2) Limited
    Transazioni
    • 28 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CASTORS INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 dic 2016Inizio dell'amministrazione
    03 gen 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jason Bell
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praticante
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    03 gen 2018Inizio della liquidazione
    12 apr 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Jason Bell
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praticante
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0