SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP

SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 02883758
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?

    Indirizzo della sede legale
    1 Kingdom Street
    W2 6BD London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP LIMITED25 nov 200525 nov 2005
    SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP PLC 13 dic 199413 dic 1994
    BARNHILL PLC01 gen 199401 gen 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Takeda Corporate Services Limited come segretario in data 31 mag 2023

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Re: the sum of usd 625,000 be capitalised / the sum of usd 29,426,000 be capitalised 30/03/2023
    RES14
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Re: cancel share premium account 30/03/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Cessazione della carica di Jonathan Clark Neal come amministratore in data 18 gen 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Gibbons come amministratore in data 08 nov 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Seyda Atadan Memis come amministratore in data 01 ago 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Peter Michael Grubin come amministratore in data 01 mar 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kentaro Shirahata come amministratore in data 01 mar 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    37 pagineAA

    Nomina di Mr Mark Gibbons come amministratore in data 30 nov 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Hugh Meryon Insall come amministratore in data 30 nov 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Shire Corporate Services Limited il 28 apr 2020

    1 pagineCH04

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2019 al 31 mar 2020

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Clark Neal il 06 feb 2020

    2 pagineCH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    33 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Damien Rodolphe Edmond Bailly come amministratore in data 06 mag 2019

    1 pagineTM01

    Assegnazione di una nuova classe di azioni da parte di una società in nome collettivo

    3 pagineSH09

    Nomina di Mr Jonathan Clark Neal come amministratore in data 12 mar 2019

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRUBIN, Peter Michael
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandAmerican293835890001
    MEMIS, Seyda Atadan
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandTurkish299191490001
    GUTHRIE, Anthony James
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    Segretario
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    British131668010002
    HARRIS, Neil Charles
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    Segretario
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    British96188470001
    MAY, Tatjana Anni Hilde
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    British75855670003
    MCLEAN, Andrew Firth
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    Segretario
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    British55993260003
    RUSSSELL, Angus Charles
    High View Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    Segretario
    High View Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    British75381100001
    STRAWBRIDGE, Oliver
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    202187490001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione11022500
    244206590002
    BAILLY, Damien Rodolphe Edmond
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    FranceFrench242039150001
    BELLINI, Francesco, Dr
    307 Rue Portland
    H3R 1V4 Ville Mont Royal
    Quebec
    Canada
    Amministratore
    307 Rue Portland
    H3R 1V4 Ville Mont Royal
    Quebec
    Canada
    Canadian76159220001
    BOWLING, James Nicholas
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish178036960001
    BOWLING, James Nicholas
    Hampshire International Busines Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Hampshire International Busines Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish178036960001
    BRANSGROVE, Roderick Granville
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    Amministratore
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United KingdomBritish48749520001
    BUCHANAN, Robin William Turnbull
    Shire Plc Hampshire International
    Business Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Shire Plc Hampshire International
    Business Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    British25905100002
    CANAVAN, Bernard
    19700 Beach Road Apartment 2 North
    Jupiter Island
    Florida
    Usa 33469
    Amministratore
    19700 Beach Road Apartment 2 North
    Jupiter Island
    Florida
    Usa 33469
    American63249680001
    CARRUTHERS, Fearghas Macgilp Kerr
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish178667180002
    CAVANAUGH, James Henry, Doctor
    Shire Plc Hampshire International
    Business Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Shire Plc Hampshire International
    Business Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    American52100100002
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CLEMENTS, Patrick Norris
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish122369120001
    CLEMENTS, Patrick Norris
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish122369120001
    EMMENS, Matthew William
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    American88969740002
    GARVEY, James
    One Beacon Street
    Boston
    FOREIGN Usa 02108
    Amministratore
    One Beacon Street
    Boston
    FOREIGN Usa 02108
    American43825460001
    GIBBONS, Mark
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandSouth African248159240001
    GRANT, James Andrews, Honorable Pc
    Shire Plc
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Chineham
    Basingstoke
    Amministratore
    Shire Plc
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Chineham
    Basingstoke
    Canadian76159160001
    GRIGGS, Roger
    7900 Tanners Gate Dr
    Suite 200
    KY 41042 Florence
    Kentucky
    Usa
    Amministratore
    7900 Tanners Gate Dr
    Suite 200
    KY 41042 Florence
    Kentucky
    Usa
    American55196760001
    HARTLEY, Daniel William David
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian184526870001
    HARTLEY, Daniel William David
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomAustralian184526870001
    HETHERINGTON, Graham Charles
    Lime Tree Way
    Hampshire Int Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    .
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lime Tree Way
    Hampshire Int Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    .
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish132396390001
    HOROVITZ, Zola, Doctor
    6110 N.W. 42nd Way
    Boca Raton
    33496
    Florida Usa
    Amministratore
    6110 N.W. 42nd Way
    Boca Raton
    33496
    Florida Usa
    American67993590001
    INSALL, Nicholas Hugh Meryon
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish248118390001
    KAPPLER, David John
    Hampshire International Business Park
    Chineham
    RG24 3EP Basingstoke
    Shire Plc
    Hampshire
    Amministratore
    Hampshire International Business Park
    Chineham
    RG24 3EP Basingstoke
    Shire Plc
    Hampshire
    EnglandBritish137007730001
    LANGLOIS, Patrick Jean Marie
    Shire Plc, Hampshire International
    Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Shire Plc, Hampshire International
    Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    French109662720001
    MARTEL, Timothy John
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish162356650001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaUnlimited With Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5492592
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 06 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dlj Capital Funding Inc.
    Transazioni
    • 06 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 05 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from shire pharmaceutical development limited to the noteholders (as defined) in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes of 1995 of spdl originally constituted by the deed poll of spdl dated 1994 or under the terms of the loan note instrument and all reasonable costs,charges and expenses incurred under or in respect of the debenture by the instructing group (as defined) or by the noteholders or by any receiver appointed under the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sun Life Nominees Limitedplease See M395 for Full Details
    • Sun Life Assurance Society PLC
    • 525 Investments Limited
    Transazioni
    • 05 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0