WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02884087 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Ann'S Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SCOTSMAN BEVERAGE SYSTEMS LIMITED | 29 giu 1999 | 29 giu 1999 |
| SCOTSMAN DRINK LIMITED | 02 feb 1994 | 02 feb 1994 |
| CITYMEET PROJECTS LIMITED | 04 gen 1994 | 04 gen 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 16 giu 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Maurice Delon Jones il 04 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 04 gen 2010 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Segretario | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Amministratore | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Amministratore | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Segretario | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||||||
| COOK, Graham Frederick | Segretario | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| NIMMO, James Alexander | Segretario | 49 Tremadol Road SW4 7NA London | British | 67637800001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Segretario | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Amministratore | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| COOK, Graham Frederick | Amministratore | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| DE ST PAER, Michael John | Amministratore | Highway Farm Great Staughton PE19 5BG St. Neots Cambridgeshire | British | 77760720002 | ||||||||||
| DOERR, Thomas | Amministratore | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| EDGE, Andrew John | Amministratore | 4 Southfields Court Albert Drive SW19 6LJ London | British | 66573870001 | ||||||||||
| HOLMES, Don | Amministratore | 775 Corporate Woods Parkway 60061 Vernon Hills Lake Illinois Usa | Us | 48648200001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Amministratore | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| KACHMER, Michael James | Amministratore | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| LEE, Richard John | Amministratore | The Gables Ledbury Road, Eastnor HR8 1EL Ledbury Herefordshire | British | 79012830002 | ||||||||||
| NIMMO, James Alexander | Amministratore | 49 Tremadol Road SW4 7NA London | British | 67637800001 | ||||||||||
| OSBORNE, Richard Cogswell | Amministratore | 465 Dundee Road 60022 Glencoe Illinois Usa | Us Citizen | 48648260001 | ||||||||||
| RUSHTON, John | Amministratore | Meadowcroft The Paddock Pedmore DY9 0RE Stourbridge West Midlands | British | 57521970001 | ||||||||||
| SPENCER, Peter David | Amministratore | The White House Broome Lane Blakedown DY10 3LP Kidderminster Worcestershire | British | 78077650001 | ||||||||||
| BERSIFORD (OVERSEAS) LIMITED | Amministratore | Theplace 175 High Holborn W1V 7AA London | 71006040002 | |||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Creato il 11 apr 2002 Consegnato il 25 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Creato il 20 feb 2002 Consegnato il 08 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Creato il 20 nov 2001 Consegnato il 30 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 12 mar 1997 Consegnato il 27 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations (being all unpaid principal of and accrued and unpaid interest on the notes,the facility letter of credit obligations(both as defined in the agreement) and all other liabilities (if any) of scotsman group inc.,the delfield company,the company,whitlenge drink equipment limited,frimont S.P.A.,castel mac S.P.A.,kysor industrial corporation and any other company admitted as a borrower pursuant to the agreement to any of the first national bank of chicago and its successors and permitted assigns arising under any of the loan documents and any rate hedging obligations (both as defined in the agreement) or foreign exchange contracts of the borrowers owing to any lender). | |
Brevi particolari Any and all deposits and any other indebtedness (as defined in the agreement) at any time held or owing by any lender to or for the credit or account of any borrower. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0