IOP 02886867 LIMITED

IOP 02886867 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIOP 02886867 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02886867
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IOP 02886867 LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova IOP 02886867 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IOP 02886867 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PEER FREEHOLDS LIMITED12 gen 199412 gen 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di IOP 02886867 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per IOP 02886867 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Martin Brendan Birrane come amministratore in data 09 giu 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione di Martin Brendan Birrane come persona con controllo significativo il 09 giu 2018

    1 paginePSC07

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Howard Dawson il 24 gen 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Peer Suite the Hop Exchange 24 Southwark Street London SE1 1TY a Two Snowhill Birmingham B4 4GA in data 22 mag 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 apr 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name27 ott 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 ott 2016

    RES15

    Bilancio redatto al 31 lug 2015

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 gen 2016

    Stato del capitale al 15 gen 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 028868670010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 028868670011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 1

    2 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di IOP 02886867 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BREEZE, Michael David
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Segretario
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    181173070001
    BIRRANE, Susan Alice
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Amministratore
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    GibraltarBritish7828640008
    BIRRANE-RULE, Amanda
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Amministratore
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    United KingdomBritish67689710002
    BREEZE, Michael David
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Amministratore
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    EnglandBritish184073430001
    DAWSON, Howard James
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Amministratore
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    EnglandBritish152733740001
    MANDER, Richard Charles
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Amministratore
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    United KingdomBritish55797010002
    SMITH, Peter James
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    Segretario
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    British7736140001
    WALLWORK, Paul Antony Hewitt
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    Segretario
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    174564620001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BIRRANE, Bridget Kathleen
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    Amministratore
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    EnglandBritish91838040001
    BIRRANE, Martin Brendan
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Amministratore
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    GibraltarIrish7736150006
    COUCHMAN, Robert Wilfred
    20 Rectory Park
    Sanderstead
    CR2 9JN South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    20 Rectory Park
    Sanderstead
    CR2 9JN South Croydon
    Surrey
    EnglandBritish159317370002
    SMITH, Peter James
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    Amministratore
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    United KingdomBritish7736140001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IOP 02886867 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Martin Brendan Birrane
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    06 apr 2016
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Nazionalità: Irish
    Paese di residenza: Gibraltar
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Peer Group Plc
    The Hop Exchange
    24 Southwark Street
    SE1 1TY London
    The Peer Suite
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Hop Exchange
    24 Southwark Street
    SE1 1TY London
    The Peer Suite
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione1265425
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    IOP 02886867 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 21 apr 2015
    Consegnato il 29 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag
    Transazioni
    • 29 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 ott 2013
    Consegnato il 06 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold land known as saxon house, sunbury, surrey (registered as SY432619). The freehold land known as centurion house, crewe gates farm industrial estate, crewe, cheshire (registered as CH393677), the freehold land known as paternoster house, brunel way, thetford, norfolk (NK174417) and all properties set out in security previously given by the company in favour of the chargee.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag
    Transazioni
    • 06 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of confirmation
    Creato il 23 ott 2012
    Consegnato il 30 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and peer freeholds (newcastle) limited to the fiance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 30 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 16 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The new property being all the f/h land and buildings k/a 34-40 windsor house, high street, esher t/no SY692349 all gross rental income as such relates to the new property; all guarantees now or in the future of all gross rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International, London Branch (The Successor Agent)
    Transazioni
    • 16 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture (supplemental to a debenture dated 30 march 2000)
    Creato il 28 ott 2002
    Consegnato il 02 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Freehold land 35, 37, 39, 41, 43, 45 and 47 high street and 2, 4, 6, 8 and 10 cromwell road redhill t/n SY475297. By way of assignment all gross rental income, all guarantees now or in the future of all gross rental income, all agreements, policies of insurance and warranties. By way of fixed charge the benefit of all rights and claims, all guarantees, warranties and representations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hvb Real Estate Capital Limited (The Facilty Agent)
    Transazioni
    • 02 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party charge over shares
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 01 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to each finance document and of the company to each finance party under or pursuant to the charge over shares
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the securities bring all stocks shares bonds and securities of any kind (marketable or otherwise) negotiable instruments and and warrants beneficially owned by the company comprised within the borrower and all interest dividends rights and benefits arising therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hvb Real Estate Capital Limited (The "Facility Agent")as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 01 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 11 lug 2000
    Consegnato il 18 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that the property k/a middle entry shopping centre tamworth t/n SF170234 property conveyed by a conveyance dated 25/03/1970 the "new properties" all gross rental income,all guarantees,all agreements policies of insurance and warranties please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hvb Real Estate Capital Limited
    Transazioni
    • 18 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hvb Real Estate Capital Limited (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture (supplemental to a debenture dated 30TH july 1996 made between the company and the bank)
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all estates or interests in mace industrial estate ashford kent t/nos.K253827 and K307368 and unit 10 maesglas retail park newport road newport gwent t/no.WA164510. By way of assignment all gross rental income and all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft (The Bank)
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 30TH july 1996 and issued by the company
    Creato il 18 nov 1996
    Consegnato il 26 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all estates or interest in the new properties being l/h-land known as pemberton house stafford court telford shropshire t/n-SL90860. F/h-land known as st martin's house hatfield hertfordshire t/n-HD244828. F/h-land known as saxon house sunbury surrey t/n-SY432619. (For the other 4 properties charged see ch microfiche). By way of assignment: all gross rental income insofar as such relates to the new properties and the rights of the company to receive the same;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Weschel-Bank Aktiengessellschaft
    Transazioni
    • 26 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 lug 1996
    Consegnato il 07 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness obligations and liabilities due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken -Und Weschel -Bank Akteingesselshaft
    Transazioni
    • 07 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 29 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    IOP 02886867 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 apr 2017Inizio della liquidazione
    09 nov 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Malcolm Cohen
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0