ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED

ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02888825
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED?

    • Trasporto passeggeri via acqua costiera e marittima (50100) / Trasporto e stoccaggio
    • Trasporto passeggeri via acqua interna (50300) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TALONGROVE TRAVEL LIMITED18 nov 199718 nov 1997
    ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED18 gen 199418 gen 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagineLIQ14

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 dic 2019

    20 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:form LIQ12 - secretary of state's release
    3 pagineLIQ MISC

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    11 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 dic 2018

    31 pagineLIQ03

    Modificazione della composizione del comitato dei creditori o del comitato di liquidazione

    11 pagineCOM2

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    36 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    19 pagineAM02

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori

    1 pagine2.26B

    Risultato della riunione dei creditori

    1 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    36 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Compass House Rockingham Road Market Harborough Leicestershire LE16 7QD a 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 22 gen 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Kenneth Harvey Charleson come amministratore in data 08 dic 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Alan Wiles come amministratore in data 29 set 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel John Arthur come amministratore in data 27 set 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 ott 2015

    29 pagineAA

    Cessazione della carica di Julie Morrison come amministratore in data 14 mar 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUCKLEY, Peter Eric
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Segretario
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    English14052080002
    ALLARD, Roger Jeffrey
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomEnglish81122260002
    BRYSON, David Angus Sibbald
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leics
    United Kingdom
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leics
    United Kingdom
    United KingdomBritish180207340001
    CORNISH, Lynn Kathleen
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish191858570001
    HORNE, Stuart Vernon
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    EnglandBritish140014470002
    MASON, Nicole Louise
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandZimbabwean114904760001
    MCKINNON, Tracey Anne
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish162927400001
    SMITH, Ian
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish5734800003
    WILSON, Colin James
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927160001
    BRYANT, Joanne
    19 Calvert Close
    TN22 2BZ Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    19 Calvert Close
    TN22 2BZ Uckfield
    East Sussex
    British37319870001
    MALEMPRE, David Victor
    24 Summerhill Close
    RH16 1QZ Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    24 Summerhill Close
    RH16 1QZ Haywards Heath
    West Sussex
    British32808800001
    STEVENS, Robert
    4 Chiltenhurst
    TN8 5PJ Edenbridge
    Kent
    Segretario
    4 Chiltenhurst
    TN8 5PJ Edenbridge
    Kent
    British83941990001
    FORBES SECRETARIES LIMITED
    8-10 Half Moon Court
    EC1A 7HE London
    Segretario nominato
    8-10 Half Moon Court
    EC1A 7HE London
    900007720001
    ALLARD, Roger Jeffrey
    4a Elystan Street
    SW3 3NS London
    Amministratore
    4a Elystan Street
    SW3 3NS London
    United KingdomEnglish81122260002
    ARTHUR, Nigel John
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    EnglandEnglish175689210001
    ATKINSON, Peter
    17 Strathfield Close
    RH16 3PF Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    17 Strathfield Close
    RH16 3PF Haywards Heath
    West Sussex
    British40511090001
    BRYANT, Robert David
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    Amministratore
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    United KingdomBritish152320790001
    BRYANT, Robert David
    Dorill
    Church Road, Buxted
    TN22 4LT Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Dorill
    Church Road, Buxted
    TN22 4LT Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish152320790001
    CHARLESON, Kenneth Harvey
    Carleton New Road
    BD23 2DE Skipton
    Kintail House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Carleton New Road
    BD23 2DE Skipton
    Kintail House
    North Yorkshire
    ScotlandBritish64180680002
    CRESSEY, Nigel David
    1 Victoria Way
    RH15 9NF Burgess Hill
    Lynnem House
    West Sussex
    England
    Amministratore
    1 Victoria Way
    RH15 9NF Burgess Hill
    Lynnem House
    West Sussex
    England
    EnglandBritish98909430002
    DEEGAN, Michael John
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    Amministratore
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    EnglandBritish98909380001
    DEWING, Joslin Luke
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    Amministratore
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    EnglandBritish165343740001
    DUFTY, Andrew
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish161857980002
    DYSON, Anthony
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish124691520001
    GADSBY, Christopher James
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish118396090002
    HUMPHRIES, Michael
    3 Paget Close
    RH13 6HD Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    3 Paget Close
    RH13 6HD Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish38432430001
    JEFFRIES, Mark Andrew
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    Amministratore
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    EnglandBritish48947500003
    JOBBER, Rosslyn Antony
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    Amministratore
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    EnglandBritish124673980001
    LAWRENCE, Geoffrey Edward
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    Amministratore
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    EnglandBritish137156080001
    MALEMPRE, David Victor
    24 Summerhill Close
    RH16 1QZ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    24 Summerhill Close
    RH16 1QZ Haywards Heath
    West Sussex
    British32808800001
    MARCHANT, Guy Stephen
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    Amministratore
    Lynnem House 1 Victoria Way
    Burgess Hill
    RH15 9NF West Sussex
    EnglandBritish128608530003
    MELARD, Helene Marthe
    29 Wordsworth Place
    RH12 5PR Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    29 Wordsworth Place
    RH12 5PR Horsham
    West Sussex
    French97673990002
    MORRIS, Neil John
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish158818060001
    MORRISON, Julie
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    EnglandBritish182193380001
    MURRAY, Alan Charles
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Compass House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish39553720002

    ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of covenant
    Creato il 07 giu 2012
    Consegnato il 15 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security agent or any other lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The ship means the vessel 'alexander von humboldt'. All rights and interests to, in or in connection with the insurances and the requisition compensation. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Roger Allard
    Transazioni
    • 15 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 15 mag 2012
    Consegnato il 01 giu 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in us dollars designated ltsb re: all leisure holidays limited and numbered 11732048 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Bank)
    Transazioni
    • 01 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 15 mag 2012
    Consegnato il 01 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 15 mag 2012
    Consegnato il 25 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re: all leisure holidays limited and numbered 02920730 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture deed
    Creato il 15 mag 2012
    Consegnato il 25 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement
    Creato il 16 gen 2003
    Consegnato il 23 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies in deposit account numbered 505501 and any account.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 23 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 25 lug 1996
    Consegnato il 02 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in a any currency deposited with the bank pursuant to the deposit being barclays bank PLC re all leisure holidays limited t/as all leisure aviation business premium account number 90086258. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 21 mar 1995
    Consegnato il 28 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Barclays bank PLC leisure holidays limited business premium account number 90866741. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    ALL LEISURE HOLIDAYS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 gen 2017Inizio dell'amministrazione
    14 dic 2017Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    14 dic 2017Inizio della liquidazione
    12 mar 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0