02890695 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società02890695 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02890695
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 02890695 LIMITED?

    • (2852) /

    Dove si trova 02890695 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Herschel House
    58 Herschel Street
    SL1 1PG Slough
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 02890695 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNNAGE TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED17 mar 199417 mar 1994
    CHELTRADING 69 LIMITED24 gen 199424 gen 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di 02890695 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per 02890695 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Notifica di revoca dell'ordinanza di amministrazione

    2 pagine2.19

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    legacy

    1 pagine287

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Relazione sulle proposte dell'amministratore

    2 pagine2.21

    Notifica del risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23

    Chi sono gli amministratori di 02890695 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WEBSTER, John Edmund
    Hazeldene Blythe Lane
    Lathom
    L40 5TY Ormskirk
    Lancashire
    Segretario
    Hazeldene Blythe Lane
    Lathom
    L40 5TY Ormskirk
    Lancashire
    British22171520001
    BRAITHWAITE, Christopher Harry
    Summerfield Wyfordby Avenue
    BB2 7AR Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    Summerfield Wyfordby Avenue
    BB2 7AR Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritishManaging Director145895100001
    JACKSON, Ronald Geoffrey
    14 Preston Road
    PR9 9EG Southport
    Merseyside
    Amministratore
    14 Preston Road
    PR9 9EG Southport
    Merseyside
    EnglandBritishSales & Marketing Director68570820002
    WEBSTER, John Edmund
    Hazeldene Blythe Lane
    Lathom
    L40 5TY Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    Hazeldene Blythe Lane
    Lathom
    L40 5TY Ormskirk
    Lancashire
    EnglandBritishGroup Finance Director22171520001
    QUADRANGLE SECRETARIES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002950001
    ALLDAY, David John
    Green House Dale Road South
    Darley Dale
    DE4 3BP Matlock
    Derbyshire
    Amministratore
    Green House Dale Road South
    Darley Dale
    DE4 3BP Matlock
    Derbyshire
    BritishExecutive14358660001
    CASTLE, Maurice Phillip
    21 Ravens Wood
    Chorley New Road
    BL1 5TL Bolton
    Amministratore
    21 Ravens Wood
    Chorley New Road
    BL1 5TL Bolton
    BritishEngineer58599860001
    CLOUGH, Leslie
    20 Havisham Close
    Lostock
    BL6 4EN Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    20 Havisham Close
    Lostock
    BL6 4EN Bolton
    Lancashire
    United KingdomEnglishCustomer Service Director57495810001
    WILCOX, Lynda
    1 Broadwell Drive
    Pennington
    WN7 3NE Leigh
    Amministratore
    1 Broadwell Drive
    Pennington
    WN7 3NE Leigh
    BritishCompany Director20961940001
    STOORNE INCORPORATIONS LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002940001
    STOORNE SERVICES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002930001

    02890695 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    First fixed charge and floating charge
    Creato il 02 set 1998
    Consegnato il 04 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book and other debts under an agreement dated 02/09/98..floating charge on all proceeds of book and other debts under or in connection with any agreement or contract for the sale and purchase of debts or under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument.
    Persone aventi diritto
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    Transazioni
    • 04 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Memorandum and charge
    Creato il 02 set 1998
    Consegnato il 04 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all the company's rights interest and title in or arising out of a factoring agreement dated 04/05/95 with the payment of any sum owing under the invoice sale and purchase agreement dated 02/09/98. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    Transazioni
    • 04 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Memorandum and charge
    Creato il 02 set 1998
    Consegnato il 04 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all the company's rights interest and title in or arising out of an invoice sale and purchase agreement dated 02/09/98 and any sum due or owing under or in connection with the factoring agreement dated 04/05/95. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alex Lawrie Factors Limited
    Transazioni
    • 04 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 mar 1998
    Consegnato il 10 apr 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Press brake machine ref 583 051171 file far pma,grinding machine ref 961008 file far pma and the other chattels detailed on the schedules to form 395 and all additions alterations accessories and renewals of component parts see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 ott 1996
    Consegnato il 06 nov 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The plant,machinery and equipment as referred in the third schedule to the deed: leyland daf diesel dropside - reg/no J697 xwb electrostatic hot spray unit - ser/no: 1634 welding machine - italy plus various other items listed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 1994
    Consegnato il 03 dic 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land together with the buildings erected thereon situate on the north west side of chew moor lane, westhoughton, bolton, greater manchester together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Collateral debenture
    Creato il 18 mar 1994
    Consegnato il 01 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from stakehill limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 1900 Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 01 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 18 mar 1994
    Consegnato il 01 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Chelwood (SE) PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mar 1994
    Consegnato il 22 mar 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)

    02890695 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 mag 2000Inizio dell'amministrazione
    05 mar 2004Amministrazione scaricata
    Ordine di amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Poxon
    Dte House
    Hollins Mount
    BL9 8AT Hollins Lane
    Bury
    Praticante
    Dte House
    Hollins Mount
    BL9 8AT Hollins Lane
    Bury
    John Malcolm Titley
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancs
    Praticante
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancs
    2
    DataTipo
    20 set 2013Conclusione della liquidazione
    05 mar 2004Data della petizione
    05 mar 2004Inizio della liquidazione
    25 dic 2013Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Manchester
    1st Floor
    Boulton House
    M1 3HY 17-21 Chorlton Street
    Manchester
    Praticante
    1st Floor
    Boulton House
    M1 3HY 17-21 Chorlton Street
    Manchester
    Elliot H Green
    Oury Clark
    Herschel House
    SL1 1PG 58 Herschel Street
    Slough Berkshire
    Praticante
    Oury Clark
    Herschel House
    SL1 1PG 58 Herschel Street
    Slough Berkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0