TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02891007 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 10 Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling Kent United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED | 18 nov 2005 | 18 nov 2005 |
| ATTENTIV SYSTEMS GROUP PLC | 18 feb 2004 | 18 feb 2004 |
| ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED | 14 gen 2004 | 14 gen 2004 |
| LYNX GROUP LIMITED | 06 giu 2002 | 06 giu 2002 |
| LYNX FINANCIAL SYSTEMS (RETAIL BANKING) LIMITED | 13 lug 1998 | 13 lug 1998 |
| QUADRA COMPUTER SERVICES LIMITED | 07 mar 1994 | 07 mar 1994 |
| QUADRA LIMITED | 25 gen 1994 | 25 gen 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Janne Kaarlo Salminen il 23 feb 2012 | 4 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Jameson come segretario in data 24 feb 2012 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Richard Jameson come amministratore in data 24 feb 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Nigel Anthony Ernest Brown come amministratore in data 23 feb 2012 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, the Arenson Centre Arenson Way Houghton Regis Dunstable Bedfordshire LU5 5UL United Kingdom in data 24 feb 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ari Peltonen come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Janne Kaarlo Salminen come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Richard Jameson il 18 feb 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ari Petteri Peltonen il 18 feb 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Paul Jameson il 18 feb 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 14 gen 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Gainsborough House Houghton Hall Park Houghton Regis Bedfordshire LU5 5XF in data 10 mag 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Nigel Anthony Ernest | Amministratore | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling 10 Kent | United Kingdom | British | 64884990001 | |||||
| SALMINEN, Janne Kaarlo | Amministratore | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling 10 Kent United Kingdom | Finland | Finnish | 161336610001 | |||||
| FAIRCLOUGH, Ian Peter | Segretario | 17 Claremont Road CV31 3EH Leamington Spa Warwickshire | British | 55444950001 | ||||||
| JAMESON, Paul | Segretario | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling 10 Kent United Kingdom | British | 108959640001 | ||||||
| MILNER, Andrew | Segretario | 12 Park Lane Upper Cumberworth HD8 8NP Huddersfield West Yorkshire | British | 62567380001 | ||||||
| SINNETT, Paul Martin | Segretario | Mill Croft Barn Water Stratford Road MK18 4PD Tingewick | British | 71468530002 | ||||||
| SINNETT, Paul Martin | Segretario | 11 The Woodlands Chesterton OX6 8TN Bicester Oxfordshire | British | 71468530001 | ||||||
| WOOD, Philip Basil | Segretario | Portelet High Street Croydon SG8 0DR Royston Hertfordshire | British | 72282230002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BERTRAM, Peter Michael | Amministratore | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | 52852920002 | |||||
| COUZENS, Michael Reginald Joseph | Amministratore | 11 Virginia Drive GU25 4RX Virginia Water Surrey | British | 91121570002 | ||||||
| DOUGLAS MANN, Stewart Charles Hamilton | Amministratore | 17 Queensdale Road W11 4SB London | England | British | 46258180001 | |||||
| FISHER, Linda Jean | Amministratore | 5 Priory Orchard Flamstead AL3 8BU St Albans Hertfordshire | British | 37491520001 | ||||||
| HOLMEN, Knut | Amministratore | Dagalivn. 25b No-0776 Oslo Norway | Norwegian | 129202940001 | ||||||
| HONE, Michael Frank | Amministratore | 3 Coniston Road Dronfield Woodhouse S18 8PY Dronfield Derbyshire | British | 37491510002 | ||||||
| JACKLIN, Ian Charles | Amministratore | 37 Brookhouse Hill Fulwood S10 3TB Sheffield South Yorkshire | England | British | 37491500001 | |||||
| JAMESON, Paul Richard | Amministratore | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4LT West Malling 10 Kent United Kingdom | England | British | 109810380001 | |||||
| KERNAHAN, Adrian Clive | Amministratore | 10 Medlows AL5 3AY Harpenden Hertfordshire | British | 29600080004 | ||||||
| LAST, Richard | Amministratore | The Leys Farm Banbury Road Great Tew OX7 4DL Chipping Norton Oxfordshire | United Kingdom | British | 80537570001 | |||||
| LINDGREN, Peter | Amministratore | Drakskeppsragen 55 Taby Se-18363 Sweden | Swedish | 106852790001 | ||||||
| LISCOMBE, David Kenneth | Amministratore | Pear Tree Farm Ainsworth Lane Crowton CW8 2RS Northwich Cheshire | British | 6387640001 | ||||||
| LUUPPALA, Harri Pentti Kalervo | Amministratore | Hakatie 15 FOREIGN Tampere Fi-33880 Finland | Finnish | 106853820001 | ||||||
| MILNER, Andrew | Amministratore | 12 Park Lane Upper Cumberworth HD8 8NP Huddersfield West Yorkshire | British | 62567380001 | ||||||
| PELTOLA, Veli Erik | Amministratore | Alberganesplanadi 9a5 FOREIGN Espoo Fi-02600 Finland | Finnish | 106852630001 | ||||||
| PELTONEN, Ari Petteri | Amministratore | Arenson Way Houghton Regis LU5 5UL Dunstable Ground Floor, The Arenson Centre Bedfordshire United Kingdom | Finland | Finnish | 139265650001 | |||||
| SINNETT, Paul Martin | Amministratore | Mill Croft Barn Water Stratford Road MK18 4PD Tingewick | England | British | 71468530002 | |||||
| WEBBER, David Paul, Mr. | Amministratore | 12 Rotten Row Great Brickhill MK17 9BA Milton Keynes Buckinghamshire | British | 47915530002 | ||||||
| WILLIAMS, David | Amministratore | 2 Seven Stiles Drive Marple SK6 6LT Stockport Cheshire | British | 57223140001 | ||||||
| WOOD, Philip Basil | Amministratore | Portelet High Street Croydon SG8 0DR Royston Hertfordshire | England | British | 72282230002 | |||||
| WYETH, David, Dr | Amministratore | 35 Barlings Road AL5 2AW Harpenden Hertfordshire | British | 4060250001 |
TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed | Creato il 25 giu 2002 Consegnato il 03 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the dnb finance parties and/or the suk finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge | Creato il 02 mar 1994 Consegnato il 08 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge upon the trade names "BS5" and "summit" floating charges upon all other the undertaking and all other property and assets of the company both present and future; any property and assets of the company both present and future by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 02 mar 1994 Consegnato il 08 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 feb 1994 Consegnato il 16 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0