TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED

TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02891007
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    Kent
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED18 nov 200518 nov 2005
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP PLC18 feb 200418 feb 2004
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED14 gen 200414 gen 2004
    LYNX GROUP LIMITED06 giu 200206 giu 2002
    LYNX FINANCIAL SYSTEMS (RETAIL BANKING) LIMITED13 lug 199813 lug 1998
    QUADRA COMPUTER SERVICES LIMITED07 mar 199407 mar 1994
    QUADRA LIMITED25 gen 199425 gen 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 feb 2013

    Stato del capitale al 05 feb 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Janne Kaarlo Salminen il 23 feb 2012

    4 pagineCH01

    Cessazione della carica di Paul Jameson come segretario in data 24 feb 2012

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Paul Richard Jameson come amministratore in data 24 feb 2012

    2 pagineTM01

    Nomina di Nigel Anthony Ernest Brown come amministratore in data 23 feb 2012

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, the Arenson Centre Arenson Way Houghton Regis Dunstable Bedfordshire LU5 5UL United Kingdom in data 24 feb 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Ari Peltonen come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Janne Kaarlo Salminen come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Richard Jameson il 18 feb 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ari Petteri Peltonen il 18 feb 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Paul Jameson il 18 feb 2011

    1 pagineCH03

    Stato del capitale al 14 gen 2011

    • Capitale: GBP 100
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem to nil 07/01/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Indirizzo della sede legale modificato da Gainsborough House Houghton Hall Park Houghton Regis Bedfordshire LU5 5XF in data 10 mag 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Nigel Anthony Ernest
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    Amministratore
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United KingdomBritish64884990001
    SALMINEN, Janne Kaarlo
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    FinlandFinnish161336610001
    FAIRCLOUGH, Ian Peter
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    British55444950001
    JAMESON, Paul
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    British108959640001
    MILNER, Andrew
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    British62567380001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Segretario
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    British71468530002
    SINNETT, Paul Martin
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    Segretario
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    British71468530001
    WOOD, Philip Basil
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    British72282230002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BERTRAM, Peter Michael
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    EnglandBritish52852920002
    COUZENS, Michael Reginald Joseph
    11 Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    11 Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    British91121570002
    DOUGLAS MANN, Stewart Charles Hamilton
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Amministratore
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    EnglandBritish46258180001
    FISHER, Linda Jean
    5 Priory Orchard
    Flamstead
    AL3 8BU St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Priory Orchard
    Flamstead
    AL3 8BU St Albans
    Hertfordshire
    British37491520001
    HOLMEN, Knut
    Dagalivn. 25b
    No-0776 Oslo
    Norway
    Amministratore
    Dagalivn. 25b
    No-0776 Oslo
    Norway
    Norwegian129202940001
    HONE, Michael Frank
    3 Coniston Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PY Dronfield
    Derbyshire
    Amministratore
    3 Coniston Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PY Dronfield
    Derbyshire
    British37491510002
    JACKLIN, Ian Charles
    37 Brookhouse Hill
    Fulwood
    S10 3TB Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    37 Brookhouse Hill
    Fulwood
    S10 3TB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish37491500001
    JAMESON, Paul Richard
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish109810380001
    KERNAHAN, Adrian Clive
    10 Medlows
    AL5 3AY Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    10 Medlows
    AL5 3AY Harpenden
    Hertfordshire
    British29600080004
    LAST, Richard
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish80537570001
    LINDGREN, Peter
    Drakskeppsragen 55
    Taby
    Se-18363
    Sweden
    Amministratore
    Drakskeppsragen 55
    Taby
    Se-18363
    Sweden
    Swedish106852790001
    LISCOMBE, David Kenneth
    Pear Tree Farm Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Pear Tree Farm Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    British6387640001
    LUUPPALA, Harri Pentti Kalervo
    Hakatie 15
    FOREIGN Tampere
    Fi-33880
    Finland
    Amministratore
    Hakatie 15
    FOREIGN Tampere
    Fi-33880
    Finland
    Finnish106853820001
    MILNER, Andrew
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    British62567380001
    PELTOLA, Veli Erik
    Alberganesplanadi 9a5
    FOREIGN Espoo
    Fi-02600
    Finland
    Amministratore
    Alberganesplanadi 9a5
    FOREIGN Espoo
    Fi-02600
    Finland
    Finnish106852630001
    PELTONEN, Ari Petteri
    Arenson Way
    Houghton Regis
    LU5 5UL Dunstable
    Ground Floor, The Arenson Centre
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Arenson Way
    Houghton Regis
    LU5 5UL Dunstable
    Ground Floor, The Arenson Centre
    Bedfordshire
    United Kingdom
    FinlandFinnish139265650001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Amministratore
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    EnglandBritish71468530002
    WEBBER, David Paul, Mr.
    12 Rotten Row
    Great Brickhill
    MK17 9BA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    12 Rotten Row
    Great Brickhill
    MK17 9BA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British47915530002
    WILLIAMS, David
    2 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    2 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    British57223140001
    WOOD, Philip Basil
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish72282230002
    WYETH, David, Dr
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    British4060250001

    TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Accession deed
    Creato il 25 giu 2002
    Consegnato il 03 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the dnb finance parties and/or the suk finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skandia UK Limited (As "Security Agent")
    Transazioni
    • 03 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Creato il 02 mar 1994
    Consegnato il 08 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge upon the trade names "BS5" and "summit" floating charges upon all other the undertaking and all other property and assets of the company both present and future; any property and assets of the company both present and future by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 mar 1994
    Consegnato il 08 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 feb 1994
    Consegnato il 16 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0