WATER FRONT LIMITED

WATER FRONT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWATER FRONT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02893802
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WATER FRONT LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova WATER FRONT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o VERNIER SPRINGS
    Fox House
    Edward Street
    B97 6HA Redditch
    Worcestershire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WATER FRONT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per WATER FRONT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2013

    Stato del capitale al 07 gen 2013

    • Capitale: GBP 9,798
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2011

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Trentham House 40-42 Red Lion Street Alvechurch Birmingham Worcestershire B48 7LF in data 15 mag 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2011 al 30 nov 2011

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Richard Mattey come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Mattey come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Kenneth Mattey il 06 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Richard Burman il 06 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Robert James Burman il 06 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Richard Kenneth Mattey il 06 nov 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di WATER FRONT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURMAN, David Richard
    c/o Vernier Springs
    Edward Street
    B97 6HA Redditch
    Fox House
    Worcestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Vernier Springs
    Edward Street
    B97 6HA Redditch
    Fox House
    Worcestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant16288670001
    BURMAN, Paul Robert James
    c/o Vernier Springs
    Edward Street
    B97 6HA Redditch
    Fox House
    Worcestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Vernier Springs
    Edward Street
    B97 6HA Redditch
    Fox House
    Worcestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director5664750002
    MATTEY, Richard Kenneth
    Trentham House
    40-42 Red Lion Street Alvechurch
    B48 7LF Birmingham
    Worcestershire
    Segretario
    Trentham House
    40-42 Red Lion Street Alvechurch
    B48 7LF Birmingham
    Worcestershire
    BritishManaging Director80594170001
    WILSON, Leigh Marian
    New Inn Farm
    Beckley
    OX3 9TY Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    New Inn Farm
    Beckley
    OX3 9TY Oxford
    Oxfordshire
    British17386190001
    JPCORS LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Segretario nominato
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001430001
    HAGGERSTONE, Brian
    36 Clifton Road
    Chesham Bois
    HP6 5PP Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    36 Clifton Road
    Chesham Bois
    HP6 5PP Amersham
    Buckinghamshire
    BritishConsultant74153200001
    MATTEY, Richard Kenneth
    Trentham House
    40-42 Red Lion Street Alvechurch
    B48 7LF Birmingham
    Worcestershire
    Amministratore
    Trentham House
    40-42 Red Lion Street Alvechurch
    B48 7LF Birmingham
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director80594170001
    NICHOLS, Christopher Francis
    47 Foxes Way
    CV34 6AY Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    47 Foxes Way
    CV34 6AY Warwick
    Warwickshire
    BritishOperations Director13198240001
    PALLAS, Ernest Rayner
    Beacon View
    Meadow Lane
    L40 4BR Lathom
    Lancashire
    Amministratore
    Beacon View
    Meadow Lane
    L40 4BR Lathom
    Lancashire
    BritishSales Manager89363460001
    STEWART, Robert William
    Underbank Old Road
    HD9 1AS Holmfirth
    114
    West Yorkshire
    Amministratore
    Underbank Old Road
    HD9 1AS Holmfirth
    114
    West Yorkshire
    BritishSales Director131622860001
    STONE, Johnathan Michael Lever
    The Hall
    East Ilsley
    RG20 7LW Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Hall
    East Ilsley
    RG20 7LW Newbury
    Berkshire
    BritishSolicitor50804220001
    WILSON, Christopher John
    New Inn Farm
    OX3 9TY Beckley
    Oxfordshire
    Amministratore
    New Inn Farm
    OX3 9TY Beckley
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant28089530003
    JPCORD LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Amministratore delegato nominato
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001420001

    WATER FRONT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 set 2009
    Consegnato il 01 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 gen 2004
    Consegnato il 31 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ge Heller Limited
    Transazioni
    • 31 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 ott 2000
    Consegnato il 26 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,680.50 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Rent deposit securing the tenant's compliance with the rents and covenants contained in a lease of 20 north oxford business centre kidlington oxon.
    Persone aventi diritto
    • Lakesmere Developments Limited
    Transazioni
    • 26 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 ott 2000
    Consegnato il 25 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £2608.50 and all interest and other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the deed
    Brevi particolari
    The interest in the deposit account of all amounts becoming due to the landlord.
    Persone aventi diritto
    • Lakesmere Developments Limited
    Transazioni
    • 25 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 gen 1999
    Consegnato il 22 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 mar 1995
    Consegnato il 15 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 feb 1995
    Consegnato il 16 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0