GARDNER LEISURE LIMITED

GARDNER LEISURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGARDNER LEISURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02894347
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GARDNER LEISURE LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova GARDNER LEISURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Haberfield Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GARDNER LEISURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TAKEOFTEN PROJECTS LIMITED03 feb 199403 feb 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di GARDNER LEISURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per GARDNER LEISURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Buckingham Bingo Albert House, 17 Bloom Street Manchester M1 3HZ in data 22 giu 2011

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Stephen Dobson come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Pearson come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Pearson come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Cunningham come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Walsh come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Jonathan James Walker come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr David Norman Rimmer come amministratore

    3 pagineAP01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 03 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2011

    Stato del capitale al 04 feb 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    3 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di GARDNER LEISURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RIMMER, David Norman
    Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Ridgefield 23
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Ridgefield 23
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritishDirector71617270002
    WALKER, Jonathan James
    Bloom Street
    M1 3HZ Manchester
    Albert House 17
    Greater Manchester
    England
    Amministratore
    Bloom Street
    M1 3HZ Manchester
    Albert House 17
    Greater Manchester
    England
    EnglandBritishAccountant39444010001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    BODILL, Gillian
    7 Mint Avenue
    Barrowford
    BB9 6JU Nelson
    Lancashire
    Segretario
    7 Mint Avenue
    Barrowford
    BB9 6JU Nelson
    Lancashire
    British37861030001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Segretario
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    BritishDirector110216340001
    PEARSON, Andrew Guy
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    Segretario
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    BritishDirector134403640001
    RICHMOND, Chantal Zenobia Renee
    3 Brookside
    Cuddington
    CW8 2QA Northwich
    Cheshire
    Segretario
    3 Brookside
    Cuddington
    CW8 2QA Northwich
    Cheshire
    BritishCompany Director17429610002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BODILL, David
    7 Mint Avenue
    Barrowford
    BB9 6JU Nelson
    Lancashire
    Amministratore
    7 Mint Avenue
    Barrowford
    BB9 6JU Nelson
    Lancashire
    BritishDirector12433480001
    CUNNINGHAM, William Andrew
    4 Goodwood Rise
    CW10 9FJ Middlewich
    Cheshire
    Amministratore
    4 Goodwood Rise
    CW10 9FJ Middlewich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector113656620001
    DOBSON, Stephen
    24 Parklands Drive
    Weston
    CW2 5FH Crewe
    Amministratore
    24 Parklands Drive
    Weston
    CW2 5FH Crewe
    United KingdomBritishDirector127852340001
    GARDNER, Michael
    24 Fountains Avenue
    Simonstone
    BB12 7PY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    24 Fountains Avenue
    Simonstone
    BB12 7PY Burnley
    Lancashire
    EnglandBritishClerical Officer38287470001
    KOSSOWSKI, Mark Sylvester
    St Jude
    Stoney Lane
    SK9 6LG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    St Jude
    Stoney Lane
    SK9 6LG Wilmslow
    Cheshire
    BritishDirector110423140001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector110216340001
    PANAYI, Panico
    Kato Drys Victoria Road
    Heaton
    BL1 5AW Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Kato Drys Victoria Road
    Heaton
    BL1 5AW Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director9075400001
    PEARSON, Andrew Guy
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    Amministratore
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    EnglandBritishDirector134403640001
    RICHMOND, Chantal Zenobia Renee
    3 Brookside
    Cuddington
    CW8 2QA Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    3 Brookside
    Cuddington
    CW8 2QA Northwich
    Cheshire
    BritishCompany Director17429610002
    TAYLOR, Graham Jack
    36 Ullswater Drive
    Killingworth
    NE12 8GX Newcastle
    Amministratore
    36 Ullswater Drive
    Killingworth
    NE12 8GX Newcastle
    BritishDirector110423300001
    WALSH, Neil
    The Paddock
    Beardwood
    BB2 7QY Blackburn
    2
    Lancashire
    Amministratore
    The Paddock
    Beardwood
    BB2 7QY Blackburn
    2
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector134469650001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GARDNER LEISURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture (fixed & floating charge)
    Creato il 01 lug 1994
    Consegnato il 20 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cambos Enterprises Limited, and Any Holding or Subsidiary Company
    Transazioni
    • 20 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of deposit.
    Creato il 01 lug 1994
    Consegnato il 18 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £30,000 and all other moneys due or to become due from the company to the council of the borough of burnley, under or pursusant to the terms of the lease .
    Brevi particolari
    A cash sum of £ 30,000 deposited with burnley borough council.
    Persone aventi diritto
    • The Council of the Borough of Burnley.
    Transazioni
    • 18 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0