TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED

TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRACKFAST INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02895113
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Avviso di ordinanza del tribunale di liquidazione

    2 pagineF14

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 feb 2012

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mar 2012

    Stato del capitale al 01 mar 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 feb 2011

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 03 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Reit (Corporate Services) Limited il 03 feb 2010

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Trafalgar Officers Limited il 03 feb 2010

    1 pagineCH02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2008

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Chi sono gli amministratori di TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    Bishop Rapallo's Ramp
    Gibraltar
    1b
    Amministratore
    Bishop Rapallo's Ramp
    Gibraltar
    1b
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6745658
    135316290001
    JACOBS, Adrian Mark
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    Segretario
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    British59392140001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Segretario
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    British127658820001
    WARD, Geoffrey Colin Neville
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    British67300170001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BAIN, Duncan Whiteford Taylor
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    British28099480001
    LE HEGARAT, Roy Frank
    La Porte
    Rue De La Porte
    Castel
    Guernsey
    Amministratore
    La Porte
    Rue De La Porte
    Castel
    Guernsey
    British59855630001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    Amministratore
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    NOE, Leopold
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    EnglandBritish64965010001
    ROBERTS, David Ian
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    British38276960001
    ROWE, John Charles
    La Boue Farmhouse
    Rue Des Vinaires
    St Peters
    Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    La Boue Farmhouse
    Rue Des Vinaires
    St Peters
    Guernsey
    Channel Islands
    British59855550003
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Amministratore
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Amministratore
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    British21120940001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of legal charge
    Creato il 01 lug 1998
    Consegnato il 14 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Myddleton house 115-123 (odd) pentonville road islington t/no.NGL495485, 1-18 corner perne road cambridge t/no.CB60462, 3,5,7 and 9 wigmore street westminster t/no.333566 Together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 14 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 24 apr 1998
    Consegnato il 13 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group member (as defined) and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of any group member (as defined) and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a myddleton house 115/123 (odd) pentonville road islington NGL495485, f/h land and buildings k/a 1/18 corner perne cambridge CB60462 and l/h car parking space at the rear of adkins corner, l/h land and buildngs k/a 3,5,7 and 9 wigmore street westminster t/n 333566 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 13 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed of legal charge
    Creato il 29 dic 1997
    Consegnato il 16 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the principal deed dated 27TH november 1997
    Brevi particolari
    The properties listed below together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance: myddleton house 115-123 (odd) pentonville road islington london t/n-NGL495485. 1-18 corner perne road cambridge t/n-CB60462. 3,5,7 & 9 wigmore street westminster t/n-333566. By way of floating charge the whole of its undertaking.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 16 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed of legal charge
    Creato il 29 dic 1997
    Consegnato il 15 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and indebtedness due or to become due from any group member (as defined) to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the principal deed dated 24TH june 1996
    Brevi particolari
    Myddleton house 115-123 (odd numbers) pentonville road islington london t/no: NGL495485; 1-18 corner perne road cambridge t/no: CB60462; 3, 5, 7 & 9 wigmore street westminster t/no: 333566 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 15 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge supplemental to a deed of debenture dated 7TH june 1994 and issued by the company
    Creato il 04 ott 1996
    Consegnato il 11 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    L/H-land being myddelton house 115 to 123 (odd) pentonville road in the L.B. of islington t/n-ngl 495485. f/h-land and buildings on the south east side of spa road bolton in the county of greater manchester t/n-gm 537000. f/h-land being omnibus depot woodbridge road guildford in the county of surrey t/n-sy 557311. and all other property by way of legal mortgage.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 07 giu 1994
    Consegnato il 22 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a 3/9 (odd numbers) wigmore street london W1 t/no.NGL419902. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 07 giu 1994
    Consegnato il 22 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land k/a 3,5,7 and 9 wigmore street london W1 t/no.333566. All that f/h land being 1 to 18 adkins corner perne road cambridge t/no. CB60462. L/h land being a parking area at the rear of adkins corner perne road cambridge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TRACKFAST INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 nov 2012Data della petizione
    31 mar 2014Conclusione della liquidazione
    14 gen 2013Inizio della liquidazione
    08 lug 2014Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0