CONTRACT NATURAL GAS LIMITED

CONTRACT NATURAL GAS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONTRACT NATURAL GAS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02897253
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CONTRACT NATURAL GAS LIMITED?

    • Distribuzione di gas combustibili attraverso condotte (35220) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata
    • Commercio di gas attraverso condotte (35230) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

    Dove si trova CONTRACT NATURAL GAS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONTRACT NATURAL GAS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al29 ott 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il29 lug 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CONTRACT NATURAL GAS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al22 gen 2022
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma05 feb 2022
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al22 gen 2021
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CONTRACT NATURAL GAS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 set 2025

    32 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 set 2024

    30 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    28 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    49 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    15 pagineAM02

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Victoria Avenue Harrogate North Yorkshire HG1 1EL England a 10 Fleet Place London England EC4M 7RB in data 04 gen 2022

    2 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 028972530015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 028972530017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 028972530016 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    25 pagineMA

    Cessazione della carica di Peter James Clarkson come amministratore in data 20 ott 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 ott 2020

    28 pagineAA

    Nomina di Mr Peter James Clarkson come amministratore in data 12 apr 2021

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CONTRACT NATURAL GAS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRANKS, Susannah
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    England
    Segretario
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    England
    266681670001
    STANLEY, Paul Robert
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    England
    EnglandBritish266675540001
    DUNLOP, Hamish Alexander
    Kirkstone
    Crabtree Green,
    LS22 5AB Collingham
    West Yorkshire
    Segretario
    Kirkstone
    Crabtree Green,
    LS22 5AB Collingham
    West Yorkshire
    British85471740001
    JONES, Timothy Peter
    3 The Crescent
    HG4 2JB Ripon
    North Yorkshire
    Segretario
    3 The Crescent
    HG4 2JB Ripon
    North Yorkshire
    British20941930001
    OXLEY, Jonathan Michael Harry
    Woodbottom Farm
    Stainburn
    LS21 2LQ Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    Woodbottom Farm
    Stainburn
    LS21 2LQ Otley
    West Yorkshire
    British33757660001
    WARD, Jean
    14 East Park Grove
    LS9 9JZ Leeds
    Westyorkshire
    Segretario
    14 East Park Grove
    LS9 9JZ Leeds
    Westyorkshire
    British44946620001
    ARENTZ, Nathan
    Berkeley Street
    W1J 8HD London
    50
    Amministratore
    Berkeley Street
    W1J 8HD London
    50
    Great BritainAustralian150711250001
    ATKINSON, Richard John
    Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UP Worcester
    96
    Worcestershire
    Amministratore
    Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UP Worcester
    96
    Worcestershire
    United KingdomBritish127985890001
    BALDISSONE, Gianluca
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish281917780001
    BODNAR, John
    Fox Farm
    Brierley Rd Shafton
    S72 8QW Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fox Farm
    Brierley Rd Shafton
    S72 8QW Barnsley
    South Yorkshire
    British108638500001
    BOUGHAN, Amman Adam Singh
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish307795070001
    CHAMBERS, Carl James
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish257019520001
    CLARKSON, Peter James
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish254427490001
    DUNLOP, Hamish Alexander
    Kirkstone
    Crabtree Green,
    LS22 5AB Collingham
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kirkstone
    Crabtree Green,
    LS22 5AB Collingham
    West Yorkshire
    British85471740001
    ENGLAND, Christopher John
    108 Tennyson Avenue
    HG1 3LF Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    108 Tennyson Avenue
    HG1 3LF Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish55333140003
    GAINES, Colin Nigel
    The Old Coach House
    Westfield Road, Tockwith
    YO26 7PY York
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Coach House
    Westfield Road, Tockwith
    YO26 7PY York
    North Yorkshire
    British80495070001
    GAINES, Pamela
    HG1
    Amministratore
    HG1
    EnglandBritish115505810004
    GIBSON, Pamela Ann
    11 Great Pasture
    LS29 7DD Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Great Pasture
    LS29 7DD Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    United KingdomBritish115505870001
    HALL, Jacqueline Louise
    1 Cornflower Way
    HG3 2WL Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Cornflower Way
    HG3 2WL Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish81876180001
    HOLLINS, Colin Richard
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish190623010001
    JONES, Timothy Peter
    3 The Crescent
    HG4 2JB Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 The Crescent
    HG4 2JB Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish20941930001
    WEBSTER, Antony John
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Victoria Avenue
    HG1 1EL Harrogate
    2
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish33148170003
    WEISBERGER, Marc Oliver
    8 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    Amministratore
    8 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    British125120590001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CONTRACT NATURAL GAS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    5 Victoria Avenue
    HG1 1EQ Harrogate
    Cng House
    England
    06 apr 2016
    5 Victoria Avenue
    HG1 1EQ Harrogate
    Cng House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleThe Laws Of England And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07341939
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CONTRACT NATURAL GAS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 mag 2020
    Consegnato il 08 giu 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Legal mortgage over real property and legal mortgage and fixed charge over intellectual property. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glencore Energy UK LTD
    Transazioni
    • 08 giu 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 05 feb 2020
    Consegnato il 11 feb 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Legal mortgage over real property and fixed charge over real property and intellectual property. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glencore Energy UK LTD
    Transazioni
    • 11 feb 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 dic 2018
    Consegnato il 14 dic 2018
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glencore Energy UK LTD
    Transazioni
    • 14 dic 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 nov 2015
    Consegnato il 12 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Legal assignment of contract monies.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 feb 2020Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 10 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 dic 2014
    Consegnato il 15 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 15 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 nov 2014
    Consegnato il 07 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed and floating charge over all assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2011
    Consegnato il 04 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transazioni
    • 04 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 gen 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 20 feb 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 18 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 05 lug 2010
    Consegnato il 10 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's present and future undertaking and assets.
    Persone aventi diritto
    • Technical & General Guarantee Company S.A.
    Transazioni
    • 10 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 gen 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 18 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge over cash sum
    Creato il 05 lug 2010
    Consegnato il 10 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interests in and to the cash sum and all the entitlements to interest the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the cash sum see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Technical & General Guarantee Company S.A.
    Transazioni
    • 10 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 gen 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 09 gen 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 04 dic 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 30 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The real property the accounts any goodwill the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Glencore Energy UK Limited
    Transazioni
    • 30 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 04 mar 2006
    Consegnato il 16 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 16 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 18 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 06 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Vanderbilt court 5 victoria avenue harrogate. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 24 feb 2003
    Consegnato il 04 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 202851.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 18 ott 2001
    Consegnato il 07 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £210,000 credited to account designation 10121371 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 apr 1999
    Consegnato il 29 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 mag 1996
    Consegnato il 12 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Technical and General Guarantee Company Limited
    Transazioni
    • 12 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 apr 1994
    Consegnato il 28 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CONTRACT NATURAL GAS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 dic 2021Inizio dell'amministrazione
    28 set 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William James Wright
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Sophie Claire Winder
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DataTipo
    28 set 2023Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Joshua James Dwyer
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    William James Wright
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Claire Sophie Winder
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0