EXOR CORPORATION LIMITED

EXOR CORPORATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXOR CORPORATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02898430
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXOR CORPORATION LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova EXOR CORPORATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    9th Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXOR CORPORATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEARNMUCH PROJECTS LIMITED15 feb 199415 feb 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXOR CORPORATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per EXOR CORPORATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2015

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mar 2016

    Stato del capitale al 04 mar 2016

    • Capitale: GBP 3,904,752.05
    SH01

    Cessazione della carica di Paul William Eaton come segretario in data 01 ott 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2014

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2015

    Stato del capitale al 14 apr 2015

    • Capitale: GBP 3,904,752.05
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2013

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 apr 2014

    Stato del capitale al 16 apr 2014

    • Capitale: GBP 3,904,752.05
    SH01

    Cessazione della carica di Stephen Voller come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2012

    25 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Nicholas Johnson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas Johnson come amministratore

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mag 2012 al 30 nov 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Indirizzo della sede legale modificato da * Clifton Heights Clifton Bristol BS8 1EJ* in data 14 nov 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mag 2011

    21 pagineAA

    Nomina di David Hollister come amministratore

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di John Lynch come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Rowlinson come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di EXOR CORPORATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOLLISTER, David
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    UsaAmerican161824250001
    JOHNSON, Andrew Neil
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    UsaBritish148386100001
    DASHFIELD, Kay Rosalind Clare
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    Segretario
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    British46710460004
    EATON, Paul William
    Copthorne Bank
    Copthorne
    RH10 3JQ Crawley
    Alford
    West Sussex
    England
    Segretario
    Copthorne Bank
    Copthorne
    RH10 3JQ Crawley
    Alford
    West Sussex
    England
    155343000001
    BYRON COMPANY SERVICES LIMITED
    7 Berkeley Square
    Clifton
    BS8 1HG Bristol
    Segretario
    7 Berkeley Square
    Clifton
    BS8 1HG Bristol
    37866710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEARDSHALL, Samuel Francis Rodney
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    Amministratore
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    United KingdomBritish47184440001
    DARKE, Lawrence Constable
    4 Ribston Mews
    GL1 5EU Gloucester
    Amministratore
    4 Ribston Mews
    GL1 5EU Gloucester
    British73000100002
    DASHFIELD, Kay Rosalind Clare
    Badgers Wood 8 Church Road
    Easton In Gordano
    BS20 0PQ Bristol
    North Somerset
    Amministratore
    Badgers Wood 8 Church Road
    Easton In Gordano
    BS20 0PQ Bristol
    North Somerset
    United KingdomBritish46710460004
    JOHNSON, Nicholas John
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor No. 20
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    9th
    United Kingdom
    EnglandBritish216618540001
    LITTLEDALE, Robert Wheatley
    Highfield The Slade
    Charlbury
    OX7 3SJ Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Highfield The Slade
    Charlbury
    OX7 3SJ Chipping Norton
    Oxfordshire
    British1450690001
    LOARRIDGE, Russell John, Mr.
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    Amministratore
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    UkBritish133183080002
    LYNCH, John Edward
    Ne 16th Street
    33304 Fort Lauderdale
    2225
    Florida
    Usa
    Amministratore
    Ne 16th Street
    33304 Fort Lauderdale
    2225
    Florida
    Usa
    UsaAmerican148387790001
    ROWLINSON, Andrew
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    Amministratore
    Clifton Heights
    Clifton
    BS8 1EJ Bristol
    EnglandBritish73000000001
    SMITH, Stephen Rhodes
    2 Princes Building
    Clifton
    BS8 4LB Bristol
    Avon
    Amministratore
    2 Princes Building
    Clifton
    BS8 4LB Bristol
    Avon
    United KingdomBritish46536530001
    TAYLOR, Bryan Lloyd
    Hatch Cottage
    Kent Street, Cowfold
    RH13 8BG Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Hatch Cottage
    Kent Street, Cowfold
    RH13 8BG Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish71356520002
    VOLLER, Stephen Roy
    The Grange
    60 West Street
    BS6 6LJ Banwell
    North Somerset
    Amministratore
    The Grange
    60 West Street
    BS6 6LJ Banwell
    North Somerset
    EnglandBritish47184600007
    WARD, John
    37 Country Road
    Mamaroneck
    Ny 10543
    Usa
    Amministratore
    37 Country Road
    Mamaroneck
    Ny 10543
    Usa
    British73000370001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    EXOR CORPORATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 ott 2008
    Consegnato il 25 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 mar 2007
    Consegnato il 14 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Hampson and Douglas Hampson
    Transazioni
    • 14 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 mar 2002
    Consegnato il 10 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Hampson, Mark O'hare and Douglas Hampson
    Transazioni
    • 10 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 26 ott 2001
    Consegnato il 02 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2000
    Consegnato il 11 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2000
    Consegnato il 03 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an investment agreement and a pik note instrument both of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 03 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 mar 1996
    Consegnato il 13 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0