NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED

NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02899075
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit D Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    West Sussex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPARKLING SPRING WATER UK LIMITED10 mag 199410 mag 1994
    WITHTRADE LIMITED16 feb 199416 feb 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Yariv Shapira come amministratore in data 05 feb 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Olivier Plouvin come amministratore in data 05 feb 2016

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 201 Bedford Avenue Slough Berkshire SL1 4RY a Unit D Fleming Centre Fleming Way Crawley West Sussex RH10 9NN in data 18 feb 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Brian Richard Macpherson come amministratore in data 05 feb 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2015

    Stato del capitale al 13 mag 2015

    • Capitale: GBP 14.73
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mag 2014

    Stato del capitale al 14 mag 2014

    • Capitale: GBP 14.73
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Maclay Murray & Spens Llp come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Sf Secretaries Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Stato del capitale al 17 gen 2011

    • Capitale: GBP 1.47
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    legacy

    2 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share prem a/c reduced to nil 23/12/2010
    RES13

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Segretario
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSO300744
    119967690001
    MACPHERSON, Brian Richard
    Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    Unit D
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    Unit D
    West Sussex
    England
    ScotlandBritish205282630001
    HARVEY, Kristine
    2 Kinneil House
    The Furlongs
    ML3 0DX Hamilton
    South Lanarkshire
    Segretario
    2 Kinneil House
    The Furlongs
    ML3 0DX Hamilton
    South Lanarkshire
    British90110940001
    HURLEY, Caroline Margaret Mary
    1 Temple Fortune Lane
    NW11 7UB London
    Segretario
    1 Temple Fortune Lane
    NW11 7UB London
    British35118780002
    STORDY, Lawrence John
    1959 Woodlawn Terrace
    Halifax
    Nova Scotia B3h 4g5
    Canada
    Segretario
    1959 Woodlawn Terrace
    Halifax
    Nova Scotia B3h 4g5
    Canada
    Canadian55997150001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Segretario nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    SF SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    123
    United Kingdom
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    123
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC128549
    900029010002
    ALLEN, Stewart Ernest
    Flat 5 1 Saint Swithins Street
    WR1 2PY Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Flat 5 1 Saint Swithins Street
    WR1 2PY Worcester
    Worcestershire
    Canadian57767250005
    BRINDLEY, Philippa Lucy
    Chemin Aime Steinlen 10
    FOREIGN Lausanne
    1004
    Switzerland
    Amministratore
    Chemin Aime Steinlen 10
    FOREIGN Lausanne
    1004
    Switzerland
    British121958280001
    CUNIA, Gadi
    Rte Des Monts-De-Lavaux 496
    La Croix-Sur-Lutry
    Ch-1090
    Switzerland
    Amministratore
    Rte Des Monts-De-Lavaux 496
    La Croix-Sur-Lutry
    Ch-1090
    Switzerland
    Israeli95798400001
    GOODICK, Arthur
    29 Fieldwood Circle
    Dartmouth Ns
    FOREIGN Nova Scotia B2w 4s5
    Canada
    Amministratore
    29 Fieldwood Circle
    Dartmouth Ns
    FOREIGN Nova Scotia B2w 4s5
    Canada
    Canadian46409180001
    GUTTINGER, Antoine Jean Yves
    Rue De Zurich,42
    FOREIGN Ch-1201, Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    Rue De Zurich,42
    FOREIGN Ch-1201, Geneva
    Switzerland
    French91634680002
    HECKER, Michael
    Ch. De La Bernadez, Ch-1094
    FOREIGN Paudex
    Switzerland
    Amministratore
    Ch. De La Bernadez, Ch-1094
    FOREIGN Paudex
    Switzerland
    Swiss95785580001
    HOWIE, William
    22 East Heath Road
    Hampstead
    NW3 1AH London
    9 Ladywell Court
    Amministratore
    22 East Heath Road
    Hampstead
    NW3 1AH London
    9 Ladywell Court
    United KingdomBritish131129520001
    HURLEY, Caroline Margaret Mary
    1 Temple Fortune Lane
    NW11 7UB London
    Amministratore
    1 Temple Fortune Lane
    NW11 7UB London
    United KingdomBritish35118780002
    KITLEY, Robert
    Old Legion Hall
    Hodnet
    TFN 3NP Market Drayton
    Shropshire
    Amministratore
    Old Legion Hall
    Hodnet
    TFN 3NP Market Drayton
    Shropshire
    British120884570001
    KITLEY, Robert Gowan
    113 Abbey Foregate
    SY2 6BA Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    113 Abbey Foregate
    SY2 6BA Shrewsbury
    Shropshire
    British74088350003
    KREDIET, Gerrit Johan
    14 Royal Court House
    162 Sloane Street
    SW1X 9BS London
    Amministratore
    14 Royal Court House
    162 Sloane Street
    SW1X 9BS London
    Dutch58139850001
    LARSON, Stephen Lawrence
    38 Briar Brae Road
    Darrien
    Connecticut
    Usa 06820
    Amministratore
    38 Briar Brae Road
    Darrien
    Connecticut
    Usa 06820
    American53746080001
    O'HARA, Kerry Ann
    16 Kingslawn Close
    SW15 6QJ London
    Amministratore
    16 Kingslawn Close
    SW15 6QJ London
    British62584140001
    PLOUVIN, Olivier
    59 Rue Du General Leclerc
    Audresy
    78570
    France
    Amministratore
    59 Rue Du General Leclerc
    Audresy
    78570
    France
    FranceFrench124866330001
    SCHICKLI, Dillon
    8951 Bald Eagle Drive
    Blaine
    Wa 98230
    Usa
    Amministratore
    8951 Bald Eagle Drive
    Blaine
    Wa 98230
    Usa
    American58715400004
    SHAPIRA, Yariv
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    Amministratore
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    IsraelIsraeli136488220001
    SHAPIRA, Yariv
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    Amministratore
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    IsraelIsraeli136488220001
    STEPHENS, Richard Wayne
    9 Bury Farm
    HP7 0SJ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 Bury Farm
    HP7 0SJ Amersham
    Buckinghamshire
    Canadian88863720001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Amministratore delegato nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Amministratore delegato nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 mag 1998
    Consegnato il 15 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee and the banks (as defined) or any of them under or pursuant to the credit agreement and or the guarantee and debenture and/or any ancillary documents contemplated by the credit agreement
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto-Dominion Bank(As Security Agent for the Banks)
    Transazioni
    • 15 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 nov 1996
    Consegnato il 27 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) under or in connection with any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 11 lug 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease dated 28TH june 1996
    Brevi particolari
    All monies deposited from time to time in the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Moatstar Limited
    Transazioni
    • 11 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 dic 1994
    Consegnato il 22 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank of Canada
    Transazioni
    • 22 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An assignment of life policy
    Creato il 19 ott 1994
    Consegnato il 26 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    All moneys thereby assured which may become payable thereunder and the full benefit thereof as a continuing security to the bank for the discharge on demand of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rental deposit
    Creato il 06 lug 1994
    Consegnato il 19 lug 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease
    Brevi particolari
    The deposit account (and all monies therein and from time to time withdrawn therefrom) maintained in the nam of russell-cooke potter & chapman at national westminster bank PLC 153 putney high street london SW15.
    Persone aventi diritto
    • Moatstar Limited
    Transazioni
    • 19 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 giu 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0