CROYDON PROPERTIES LIMITED

CROYDON PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCROYDON PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02902133
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CROYDON PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova CROYDON PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CROYDON PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CROYDON PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Alexander Edward Compton Hare come amministratore in data 05 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come segretario in data 05 ott 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come amministratore in data 05 ott 2016

    1 pagineTM01

    Stato del capitale al 30 set 2016

    • Capitale: GBP 100
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Simon Geoffrey Carter come amministratore in data 27 giu 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Sandra Judith Odell come amministratore in data 27 giu 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 27 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Maxwell David Shaw James come amministratore in data 27 giu 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mar 2016

    Stato del capitale al 10 mar 2016

    • Capitale: GBP 5,487,584
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maxwell David Shaw James il 26 feb 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 26 mag 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Geoffrey Carter come amministratore in data 26 mag 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 31 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard James Stearn come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2015

    Stato del capitale al 26 feb 2015

    • Capitale: GBP 5,487,584
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maxwell David Shaw James il 04 ago 2014

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CROYDON PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant196504990001
    HARE, Alexander Edward Compton
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant215786330001
    ALLY, Bibi Rahima
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    Segretario
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    British38963210001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Segretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HICKSON, Robin Lister
    23 Meadowbrook
    RH8 9LT Oxted
    Surrey
    Segretario
    23 Meadowbrook
    RH8 9LT Oxted
    Surrey
    BritishChartered Accountant39528960002
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    BritishChartered Accountant23950030001
    KNOWLES, Elizabeth Christine
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Segretario
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    BritishChartered Surveyor37512410001
    KNOWLES, Elizabeth Christine
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Segretario
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    BritishChartered Surveyor37512410001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Segretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    174832630001
    RICE, Sarah Jane
    12 Rangers Square
    Greenwich
    SE10 8HR London
    Segretario
    12 Rangers Square
    Greenwich
    SE10 8HR London
    BritishAccountant72584080001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    BritishAccountant66939460001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Segretario
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    BritishSolicitor43632680001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    BLAXLAND, Richard Bryan
    Gleamingwood
    10 Walderslade Road
    ME4 6NX Chatham
    Kent
    Amministratore
    Gleamingwood
    10 Walderslade Road
    ME4 6NX Chatham
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant9530670001
    BLOOR, Gordon
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Amministratore
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    BritishCompany Director38998390001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant184444990001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Amministratore
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    BritishCompany Director32267100002
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Amministratore
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Amministratore
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralianProperty Fund Manager94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    BritishDirector14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Amministratore
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritishFund Manager151855940001
    GODDARD, Terence Philip
    St Annes Grange
    MK17 0BH Newton Longville
    Bucks
    Amministratore
    St Annes Grange
    MK17 0BH Newton Longville
    Bucks
    EnglandBritishCompany Director15955560001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Amministratore
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritishDirector84913850002
    HEWITT, Roger Paul
    101 Harestone Valley Road
    CR3 6HR Caterham
    Surrey
    Amministratore
    101 Harestone Valley Road
    CR3 6HR Caterham
    Surrey
    EnglandBritishChartyered Surveyor49966910001
    HICKSON, Robin Lister
    23 Meadowbrook
    RH8 9LT Oxted
    Surrey
    Amministratore
    23 Meadowbrook
    RH8 9LT Oxted
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant39528960002
    HINDE, Robert Walter
    Old Pond Farm
    Harvel
    DA13 0BS Gravesend
    Kent
    Amministratore
    Old Pond Farm
    Harvel
    DA13 0BS Gravesend
    Kent
    BritishCompany Director3224990001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director164108510003
    KNOWLES, Elizabeth Christine
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Amministratore
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    BritishChartered Surveyor37512410001
    KNOWLES, Elizabeth Christine
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Amministratore
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    BritishChartered Surveyor37512410001
    MACKANESS, Alexandra Antonia
    156 Campden Hill Road
    W8 7AS London
    Amministratore
    156 Campden Hill Road
    W8 7AS London
    BritishInvestment Banker39096000001
    MASTERSON, Christopher Mary
    19 Tower Road
    TW14 4PD Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    19 Tower Road
    TW14 4PD Twickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director35526310001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary132142980001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor94724020002

    CROYDON PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 04 feb 2008
    Consegnato il 15 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 01 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 01 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 22 ott 2007
    Consegnato il 25 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 20 lug 2004
    Consegnato il 28 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements by way of a first floating charge all assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Lender)
    Transazioni
    • 28 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 20 lug 2004
    Consegnato il 23 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Facility Agent) as Agent and Trustee Forthe Finance Parties
    Transazioni
    • 23 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between the company and bayerische hypo- und vereinsbank aktiengesellschaft, london branch
    Creato il 17 feb 1999
    Consegnato il 18 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due from the company to the finance party under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branchas Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 18 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 29 lug 1996
    Consegnato il 08 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    The land comprised in a transfer dated 1ST july 1996 being land on the east side of beddington farm road (the "security assets") together with all rental income and any guarantee of rental income contained in or relating to any lease and fixtures on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbrief- Und- Hypothekenbank AKTIEGESELLSCHAFT0
    Transazioni
    • 08 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 21 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 mag 1994
    Consegnato il 17 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 17 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0