CASSEL PROPERTIES LIMITED

CASSEL PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASSEL PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02906143
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DE FACTO 343 LIMITED08 mar 199408 mar 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mar 2013

    Stato del capitale al 15 mar 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2012

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2011

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    16 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    15 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Trafalgar Officers Limited il 02 mar 2010

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Reit(Corporate Services) Limited il 09 dic 2009

    1 pagineCH04

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    15 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Quoting section 175 of the companies act 2006 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Quoting section 175 of the companies act 2006 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Quoting section 175 of the companies act 2006 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Quoting section 175 of the companies act 2006 10/11/2008
    RES13

    Chi sono gli amministratori di CASSEL PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Amministratore
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6745658
    135316290001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Segretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Segretario nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Amministratore
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Amministratore
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Amministratore
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    CASSEL PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 05 set 2007
    Consegnato il 12 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the all assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transazioni
    • 12 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 09 giu 1999
    Consegnato il 14 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bradmarsh business park,temple row,rotherham. T/no SYK395251; land on the east side of millshaw ring road, beeston, leeds, t/no WYK582753 and WYK633485; land on the north side of university, boulevard, stockton on tees t/no CE137161.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 27 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of performance bond
    Creato il 08 lug 1997
    Consegnato il 10 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The loan facility of £7,100,000 made available by the chargee to the company pursuant to a facility letter dated 6TH december 1996
    Brevi particolari
    The benefit of a perforamce bond made 14TH may 1997 between gmi construction group PLC and de montfort insurance company PLC and the company in the sum of £354,995.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 10 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of performance bond
    Creato il 18 giu 1997
    Consegnato il 27 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The loan facility of £7,100,000 made availible by the chargee to the company pursuant to a facility letter dated 6TH december 1996
    Brevi particolari
    The benefit of a performance bond made 6TH may 1997 between gmi construction group PLC and de montfort insurance company PLC and the company in the sum of £393,490.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 27 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 giu 1997
    Consegnato il 23 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter dated 6 december 1996 in respect of loan facility of up to £7,100,000 and this charge
    Brevi particolari
    The f/h land at barclay house,stockton upon tees.t/no.CE137161 and land at millshaw,leeds.t/no.WYK582753. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generaleas Agent for the Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 23 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 mag 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 dic 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0