JUPITEC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJUPITEC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02906155
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JUPITEC LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova JUPITEC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    PO BOX 501 The Nexus Building
    Broadway
    SG6 9BL Letchworth Garden City
    Herts
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JUPITEC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JUPITEC TRAINING & UAT SOLUTIONS LIMITED13 set 199913 set 1999
    JUPITEC LTD24 apr 199824 apr 1998
    OGRAM PROJECT & TRAINING CONSULTANCY LIMITED09 set 199609 set 1996
    OGRAM MEDIA ENTERPRISES LIMITED 08 mar 199408 mar 1994

    Quali sono le ultime deposizioni per JUPITEC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Carole Dean come segretario in data 29 nov 2012

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Carole Anne Dean come amministratore in data 29 nov 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Nathan Stuart Arter come amministratore in data 29 nov 2012

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2012

    Stato del capitale al 14 mar 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da PO Box PO Box 501 the Nexus Building Broadway Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 9BL United Kingdom in data 13 mag 2011

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Premier Gate 21 Easthampstead Road Bracknell Berkshire RG12 1JS in data 25 nov 2010

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Kings Parade, Lower Coombe Street, Croydon Surrey CR0 1AA in data 23 nov 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Matthew Huddleston come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Matthew Huddleston come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Carole Dean come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Carole Dean come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    2 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di JUPITEC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARTER, Nathan Stuart
    The Nexus Building
    Broadway
    SG6 9BL Letchworth Garden City
    PO BOX 501
    Herts
    England
    Amministratore
    The Nexus Building
    Broadway
    SG6 9BL Letchworth Garden City
    PO BOX 501
    Herts
    England
    United KingdomBritish174207720001
    BIRRELL, Lisa Joanne
    1 Pine Villas
    Longmoor Road, Greatham
    GU33 6AN Liss
    Hampshire
    Segretario
    1 Pine Villas
    Longmoor Road, Greatham
    GU33 6AN Liss
    Hampshire
    British76837650001
    CONWAY, Robert
    18 Barnwell House
    St Giles Road
    SE5 7RP London
    Segretario nominato
    18 Barnwell House
    St Giles Road
    SE5 7RP London
    British900002090001
    DEAN, Carole
    GL8 8SH Cherington
    Grove Farm
    Gloucestershire
    Segretario
    GL8 8SH Cherington
    Grove Farm
    Gloucestershire
    British149434720001
    DODD-WILSON, Timothy Paul
    186 Connaught Road
    Brookwood
    GU24 0AH Woking
    Surrey
    Segretario
    186 Connaught Road
    Brookwood
    GU24 0AH Woking
    Surrey
    British45125460004
    HUDDLESTON, Matthew
    Erin Way
    IM9 6EF Port Erin
    9
    Isle Of Man
    Segretario
    Erin Way
    IM9 6EF Port Erin
    9
    Isle Of Man
    British164035480001
    KEMP, Brian Paul
    4 Darfield Road
    GU4 7YY Guildford
    Surrey
    Segretario
    4 Darfield Road
    GU4 7YY Guildford
    Surrey
    British65706170001
    MOORE, Joanne Elizabeth
    3 Twelve Acre Close
    Bookham
    KT23 3HF Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    3 Twelve Acre Close
    Bookham
    KT23 3HF Leatherhead
    Surrey
    British66007500002
    STOCKMAN, Adrian
    Oaklands
    50 Forest Road
    GU33 7BL Liss
    Hampshire
    Segretario
    Oaklands
    50 Forest Road
    GU33 7BL Liss
    Hampshire
    British70331400004
    SYKES, Helen Eleanor Henderson
    130 Craigbank Street
    Strutherhill
    ML9 1JP Larkhall
    Lanarkshire
    Segretario
    130 Craigbank Street
    Strutherhill
    ML9 1JP Larkhall
    Lanarkshire
    British38352520001
    WILSON, William
    74 Hyndford Road
    ML11 9AU Lanark
    Lanarkshire
    Segretario
    74 Hyndford Road
    ML11 9AU Lanark
    Lanarkshire
    British1344100002
    BIRRELL, Lisa Joanne
    1 Pine Villas
    Longmoor Road, Greatham
    GU33 6AN Liss
    Hampshire
    Amministratore
    1 Pine Villas
    Longmoor Road, Greatham
    GU33 6AN Liss
    Hampshire
    British76837650001
    COWAN, Graham Michael
    Gloucester Road
    EN5 1RT New Barnet
    16
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    Gloucester Road
    EN5 1RT New Barnet
    16
    Hertfordshire
    United KingdomBritish900002410001
    DEAN, Carole Anne
    GL8 8SH Cherington
    Grove Farm
    Gloucestershire
    Amministratore
    GL8 8SH Cherington
    Grove Farm
    Gloucestershire
    United KingdomBritish146925480001
    DODD WILSON, Margot
    25 The Gateway
    Woodham
    GU21 5SN Woking
    Surrey
    Amministratore
    25 The Gateway
    Woodham
    GU21 5SN Woking
    Surrey
    British38352580010
    DODD-WILSON, Timothy Paul
    Southlands Guildford Road
    GU22 7UW Woking
    Surrey
    Amministratore
    Southlands Guildford Road
    GU22 7UW Woking
    Surrey
    British45125460005
    FLORA, Parminder
    11 Ling Drive
    GU18 5PA Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    11 Ling Drive
    GU18 5PA Lightwater
    Surrey
    United KingdomBritish49464480002
    GATEHOUSE, Peter John
    70 North Street
    EN9 2NW Nazeing
    Essex
    Amministratore
    70 North Street
    EN9 2NW Nazeing
    Essex
    United KingdomBritish76202490004
    HARTGROVE, Kim Elizabeth
    2 Clapgate Cottage
    Dry Street
    SS16 5LX Langdon Hills
    Essex
    Amministratore
    2 Clapgate Cottage
    Dry Street
    SS16 5LX Langdon Hills
    Essex
    United KingdomBritish127293750001
    HUDDLESTON, Matthew
    Erin Way
    IM9 6EF Port Erin
    9
    Isle Of Man
    Amministratore
    Erin Way
    IM9 6EF Port Erin
    9
    Isle Of Man
    United KingdomBritish164035480001
    KEMP, Brian Paul
    4 Darfield Road
    GU4 7YY Guildford
    Surrey
    Amministratore
    4 Darfield Road
    GU4 7YY Guildford
    Surrey
    EnglandBritish65706170001
    MEHTA, Neil
    6 Annandale Drive
    Lower Bourne
    GU10 3JD Farnham
    Surrey
    Amministratore
    6 Annandale Drive
    Lower Bourne
    GU10 3JD Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish49464440003
    MOORE, Joanne Elizabeth
    3 Twelve Acre Close
    Bookham
    KT23 3HF Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    3 Twelve Acre Close
    Bookham
    KT23 3HF Leatherhead
    Surrey
    British66007500002
    SNOWDEN, Paul Anthony
    59 Cardinal Avenue
    WD6 1EN Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    59 Cardinal Avenue
    WD6 1EN Borehamwood
    Hertfordshire
    British81161930001
    STOCKMAN, Adrian
    Oaklands
    50 Forest Road
    GU33 7BL Liss
    Hampshire
    Amministratore
    Oaklands
    50 Forest Road
    GU33 7BL Liss
    Hampshire
    British70331400004
    THOMPSON, Linda
    10 Northfield
    Witley
    GU8 5LN Godalming
    Surrey
    Amministratore
    10 Northfield
    Witley
    GU8 5LN Godalming
    Surrey
    British60843710001
    WILSON, William
    74 Hyndford Road
    ML11 9AU Lanark
    Lanarkshire
    Amministratore
    74 Hyndford Road
    ML11 9AU Lanark
    Lanarkshire
    British1344100002

    JUPITEC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite all assets guarantee and debenture
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 07 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 07 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 dic 2001
    Consegnato il 17 dic 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the factoring agreement as defined in the fixed and floating charge.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 17 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture
    Creato il 30 ago 2001
    Consegnato il 01 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the financing agreement (as defined)
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited T/a Alex Lawrie Factors
    Transazioni
    • 01 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ago 2000
    Consegnato il 31 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 nov 1997
    Consegnato il 21 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease and/or this deed
    Brevi particolari
    Security deposit of £8,500.
    Persone aventi diritto
    • Hann Tucker Associates Limited
    Transazioni
    • 21 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0