NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED

NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02906527
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHRYSALIS TELEVISION MIDLANDS LIMITED11 dic 200211 dic 2002
    CHRYSALIS ENTERTAINMENT LIMITED 02 mar 200102 mar 2001
    WATCHMAKER PRODUCTIONS LIMITED09 mar 199409 mar 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2016

    Stato del capitale al 14 mar 2016

    • Capitale: GBP 500,100
    SH01

    Cessazione della carica di Robert John Johnston Brown come segretario in data 12 nov 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Robert John Johnston Brown come amministratore in data 12 nov 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Angela Mcmullen come segretario in data 12 nov 2015

    2 pagineAP03

    Nomina di Ms Angela Mcmullen come amministratore in data 12 nov 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Victoria Jane Turton il 25 ago 2015

    2 pagineCH01

    Nomina di Ms Sara Kate Geater come amministratore in data 01 mag 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Robert John Johnston Brown come amministratore in data 30 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Robert John Johnston Brown come segretario in data 30 apr 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Neil Irvine Bright come amministratore in data 30 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Irvine Bright come segretario in data 30 apr 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 09 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2015

    Stato del capitale al 09 mar 2015

    • Capitale: GBP 500,100
    SH01

    Cessazione della carica di Stephen Roger Morrison come amministratore in data 24 set 2014

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ago 2014 al 31 dic 2014

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2014

    Stato del capitale al 17 mar 2014

    • Capitale: GBP 500,100
    SH01

    Nomina di Neil Irvine Bright come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Neil Irvine Bright come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Adam Jones come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCMULLEN, Angela
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Segretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    202644090001
    GEATER, Sara Kate
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish98319220002
    MCMULLEN, Angela
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish202627200001
    TURTON, Victoria Jane
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish46116480001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Segretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    181020820001
    BROWN, Robert John Johnston
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Segretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    197749270001
    JONES, Adam Maxwell
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Segretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    156806080001
    PFEIL, John Christopher
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Segretario
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    British93412530001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    MARYLEBONE SECRETARIES LIMITED
    Regina House
    124 Finchley Road
    NW3 5JS London
    Segretario
    Regina House
    124 Finchley Road
    NW3 5JS London
    36806500003
    BEDELL, Elaine Anne
    28 Malvern Road
    E8 3LP London
    Amministratore
    28 Malvern Road
    E8 3LP London
    EnglandBritish40408170001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish180993450001
    BROWN, Robert John Johnston
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish120406860001
    BURNS, Julian Delisle
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish17986720005
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Amministratore
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritish36186210001
    COLPANI, Paola
    Little Garth
    Crutches Lane, Jordans
    HP9 2TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Garth
    Crutches Lane, Jordans
    HP9 2TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Italian68180770001
    DREWETT, Richard Searle
    67 Cole Park Road
    TW1 1HT Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    67 Cole Park Road
    TW1 1HT Twickenham
    Middlesex
    British32319910001
    DUNCANSON, Neil Alexander
    3 The Fairway
    RM14 1BS Upminster
    Essex
    Amministratore
    3 The Fairway
    RM14 1BS Upminster
    Essex
    EnglandBritish20540470002
    HANCOCK, Roger Thomas
    Bedford House 79 Marine Parade
    BN2 1AJ Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    Bedford House 79 Marine Parade
    BN2 1AJ Brighton
    East Sussex
    British15363800001
    JAMES, Clive Vivian
    536 Willoughby House
    Barbican
    EC2Y 8BN London
    Amministratore
    536 Willoughby House
    Barbican
    EC2Y 8BN London
    British71516870002
    JONES, Adam Maxwell
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish124674500006
    LENTON, Paul Richard
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    Amministratore
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    EnglandBritish82173510001
    MORRISON, Stephen Roger
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish63326820002
    NORTH, Norman Peter
    13a Bellevue Road
    SW17 7EG London
    Amministratore
    13a Bellevue Road
    SW17 7EG London
    British43663740002
    PFEIL, John Christopher
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish93412530001
    PILSWORTH, Michael John
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    Amministratore
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    British82502160001
    SPURGEON, Christopher Nigel
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    Amministratore
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    United KingdomBritish95569230001
    WOHLGEMUTH, John Richard Steven
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    Amministratore
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    British38684180002
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02315596
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 21 giu 2005
    Consegnato il 09 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each group company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 09 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chrysalis Group PLC
    Transazioni
    • 09 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 09 ott 1998
    Consegnato il 13 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and/or future indebtedness of the company to the chargee on any account in connection with the film project (as defined) and all other liabilities under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All of its rights title and interest in and to the following in relation to the film project in all media and in all territories throughout the world to the full extent of its interest therein as follows:- (a) all literary property and ancillary rights in relation to the film project.(b) all rights to lease licence sell or otherwise deal with and exploit all rights in the film project.(c) all contracts and contract rights,agreements for personal services or otherwise.(d) all other rights and properties acquired or to be acquired by the company in connection with the film project.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Ireland Film Commission
    Transazioni
    • 13 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 17 lug 1995
    Consegnato il 21 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0