NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02906527 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CHRYSALIS TELEVISION MIDLANDS LIMITED | 11 dic 2002 | 11 dic 2002 |
| CHRYSALIS ENTERTAINMENT LIMITED | 02 mar 2001 | 02 mar 2001 |
| WATCHMAKER PRODUCTIONS LIMITED | 09 mar 1994 | 09 mar 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Robert John Johnston Brown come segretario in data 12 nov 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert John Johnston Brown come amministratore in data 12 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Angela Mcmullen come segretario in data 12 nov 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Ms Angela Mcmullen come amministratore in data 12 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Victoria Jane Turton il 25 ago 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Ms Sara Kate Geater come amministratore in data 01 mag 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert John Johnston Brown come amministratore in data 30 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Robert John Johnston Brown come segretario in data 30 apr 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Irvine Bright come amministratore in data 30 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Irvine Bright come segretario in data 30 apr 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Roger Morrison come amministratore in data 24 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ago 2014 al 31 dic 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Neil Irvine Bright come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Neil Irvine Bright come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Adam Jones come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMULLEN, Angela | Segretario | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | 202644090001 | |||||||
| GEATER, Sara Kate | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | England | British | 98319220002 | |||||
| MCMULLEN, Angela | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | England | British | 202627200001 | |||||
| TURTON, Victoria Jane | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | England | British | 46116480001 | |||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Segretario | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | 181020820001 | |||||||
| BROWN, Robert John Johnston | Segretario | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | 197749270001 | |||||||
| JONES, Adam Maxwell | Segretario | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | 156806080001 | |||||||
| PFEIL, John Christopher | Segretario | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | British | 93412530001 | ||||||
| POTTERELL, Clive Ronald | Segretario | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | British | 3182530002 | ||||||
| CCS SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900001720001 | |||||||
| MARYLEBONE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Regina House 124 Finchley Road NW3 5JS London | 36806500003 | |||||||
| BEDELL, Elaine Anne | Amministratore | 28 Malvern Road E8 3LP London | England | British | 40408170001 | |||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | United Kingdom | British | 180993450001 | |||||
| BROWN, Robert John Johnston | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | United Kingdom | British | 120406860001 | |||||
| BURNS, Julian Delisle | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | United Kingdom | British | 17986720005 | |||||
| BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson | Amministratore | Bullrush Farm Hillgrove Lurgashall GU28 9EP Petworth West Sussex | United Kingdom | British | 36186210001 | |||||
| COLPANI, Paola | Amministratore | Little Garth Crutches Lane, Jordans HP9 2TG Beaconsfield Buckinghamshire | Italian | 68180770001 | ||||||
| DREWETT, Richard Searle | Amministratore | 67 Cole Park Road TW1 1HT Twickenham Middlesex | British | 32319910001 | ||||||
| DUNCANSON, Neil Alexander | Amministratore | 3 The Fairway RM14 1BS Upminster Essex | England | British | 20540470002 | |||||
| HANCOCK, Roger Thomas | Amministratore | Bedford House 79 Marine Parade BN2 1AJ Brighton East Sussex | British | 15363800001 | ||||||
| JAMES, Clive Vivian | Amministratore | 536 Willoughby House Barbican EC2Y 8BN London | British | 71516870002 | ||||||
| JONES, Adam Maxwell | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | United Kingdom | British | 124674500006 | |||||
| LENTON, Paul Richard | Amministratore | 27 Great Bushey Drive Totteridge N20 8QN London | England | British | 82173510001 | |||||
| MORRISON, Stephen Roger | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | United Kingdom | British | 63326820002 | |||||
| NORTH, Norman Peter | Amministratore | 13a Bellevue Road SW17 7EG London | British | 43663740002 | ||||||
| PFEIL, John Christopher | Amministratore | Berkshire House 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London | England | British | 93412530001 | |||||
| PILSWORTH, Michael John | Amministratore | Glebe House Church Lane LU6 2DJ Eaton Bray Bedfordshire | British | 82502160001 | ||||||
| SPURGEON, Christopher Nigel | Amministratore | 91 Lonsdale Road Barnes SW13 9DA London | United Kingdom | British | 95569230001 | |||||
| WOHLGEMUTH, John Richard Steven | Amministratore | 48d Primrose Hill Road NW3 3AA London | British | 38684180002 | ||||||
| CCS DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900001710001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North One Television Limited | 06 apr 2016 | 168 - 173 High Holborn WC1V 7AA London Berkshire House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Creato il 21 giu 2005 Consegnato il 09 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each group company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 29 ago 2003 Consegnato il 09 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 29 ago 2003 Consegnato il 06 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 09 ott 1998 Consegnato il 13 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and/or future indebtedness of the company to the chargee on any account in connection with the film project (as defined) and all other liabilities under the terms of the charge | |
Brevi particolari All of its rights title and interest in and to the following in relation to the film project in all media and in all territories throughout the world to the full extent of its interest therein as follows:- (a) all literary property and ancillary rights in relation to the film project.(b) all rights to lease licence sell or otherwise deal with and exploit all rights in the film project.(c) all contracts and contract rights,agreements for personal services or otherwise.(d) all other rights and properties acquired or to be acquired by the company in connection with the film project.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 17 lug 1995 Consegnato il 21 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0