ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02911600 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED?
- Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione
- Pub e bar (56302) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O KROLL ADVISORY LTD The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| UGLY BOB'S ENTERTAINMENTS LIMITED | 17 mag 1994 | 17 mag 1994 |
| WANECREST LIMITED | 23 mar 1994 | 23 mar 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 01 gen 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma | |
|---|---|
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 24 mar 2024 |
Quali sono le ultime deposizioni per ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 43 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Domanda di insolvenza Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 pagine | LIQ MISC | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 19 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 20 giu 2024 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 10 pagine | MA | ||||||||||
Stato del capitale al 04 dic 2023
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 01 gen 2023 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Robert Lee come amministratore in data 31 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Nicholas D'cruz come amministratore in data 31 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 02 gen 2022 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Smothers come amministratore in data 15 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Robert Lee come amministratore in data 15 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 03 gen 2021 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Segretario | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | 207526210001 | |||||||
| D'CRUZ, Simon Nicholas | Amministratore | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | United Kingdom | British | 242723610001 | |||||
| BARKER, Jack | Segretario | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | 34404400001 | ||||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Segretario | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Segretario nominato | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| FROUD, Keith | Segretario | 12 Cavalier Drive Apperley Bridge BD10 0UF Bradford West Yorkshire | British | 54853670002 | ||||||
| JONES, Clare Adele | Segretario | 10 Heddon Place Headingley LS6 4EL Leeds West Yorkshire | British | 50145210001 | ||||||
| JONES, Henry | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180591760001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Segretario | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445510001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Segretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181022350001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| TEARLE, Frank John | Segretario | Allerton Hall Cottage Allerton Hall Courtyard Wensley Ave LS7 1QX Chapel Allerton Leeds West Yorkshire | British | 45004040002 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BARKER, Jack | Amministratore | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | 34404400001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Amministratore | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| BUTLER, Philip Stanley | Amministratore | Garden House Skelton YO3 6XY York Yorkshire | England | British | 32490610001 | |||||
| DANIELS, Colin | Amministratore | Brooklands 313 Batley Road WF2 0AP Wakefield West Yorkshire | British | 1278190001 | ||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| DOYLE, Betty June | Amministratore delegato nominato | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
| DUTTON, Philip | Amministratore | 23 Quarry Dene LS16 8PA Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| DWYER, Daniel John | Amministratore delegato nominato | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| GALLAGHER, Patrick James | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GRANT, Martin James | Amministratore | Oak House Waverley Edge CV8 3LW Bubbenhall Warwickshire | Uk | British | 82731440001 | |||||
| GRIMES, Michael Leonard Julian | Amministratore | 27 Mountfields Clarendon Road LS2 9PQ Leeds West Yorkshire | British | 33571640001 | ||||||
| JONES, John Graham | Amministratore | Lowick House 41 Creskeld Lane Bramhope LS16 9EP Leeds West Yorkshire | British | 35569170001 | ||||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Amministratore | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LEE, Matthew Robert | Amministratore | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | England | British | 286667680001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Amministratore | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MCKEOWN, John Wilson | Amministratore | 1 Swithland Lane LE7 7SG Rothley Leicestershire | British | 2126530001 | ||||||
| MEEHAN, Paul Alan | Amministratore | House, Park Farm Newton Hall Lane Mobberley WA16 7LQ Knutsford The Farm Cheshire United Kingdom | England | British | 130608590001 | |||||
| MORRIS, Roisin Elish | Amministratore | 5 Vivienne Close Cambridge Park TW1 2JX Twickenham Middlesex | England | British | 73692540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit (Ake Holdings) Limited | 06 apr 2016 | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ALLIED KUNICK ENTERTAINMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0