C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED

C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàC.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02912426
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O CLC GROUP LTD
    Unit 2 Vincent Avenue
    SO16 6PQ Southampton
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIMMS DECORATIONS LIMITED11 lug 200611 lug 2006
    ROLLAND GROUP LIMITED08 mag 200608 mag 2006
    SIMMS DECORATIONS LIMITED26 apr 199426 apr 1994
    KITDELUXE TRADING LIMITED24 mar 199424 mar 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2013

    Stato del capitale al 27 mar 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Benjamin Thomas Armitage il 07 apr 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Malcolm John White il 01 mar 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Malcolm John White il 01 mar 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Clc Group Plc Vincent Avenue Shirley Southampton Hampshire SO16 6PQ in data 26 apr 2010

    1 pagineAD01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed simms decorations LIMITED\certificate issued on 19/04/10
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name19 apr 2010

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 25 mar 2010

    RES15

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITE, Malcolm John
    c/o C/O Clc Group Ltd
    Vincent Avenue
    SO16 6PQ Southampton
    Unit 2
    England
    Segretario
    c/o C/O Clc Group Ltd
    Vincent Avenue
    SO16 6PQ Southampton
    Unit 2
    England
    BritishAccountant110398690001
    ARMITAGE, Peter Benjamin Thomas
    c/o C/O Clc Group Ltd
    Vincent Avenue
    SO16 6PQ Southampton
    Unit 2
    England
    Amministratore
    c/o C/O Clc Group Ltd
    Vincent Avenue
    SO16 6PQ Southampton
    Unit 2
    England
    EnglandBritishManaging Director72943340001
    WHITE, Malcolm John
    C/O Clc Group Plc
    Vincent Avenue Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    C/O Clc Group Plc
    Vincent Avenue Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant110398690002
    EAVES, Terence Joseph
    86 Spencer Road
    PO33 3AH Ryde
    Isle Of Wight
    Segretario
    86 Spencer Road
    PO33 3AH Ryde
    Isle Of Wight
    BritishAccountant125796830001
    GLEAVE, Linda Margaret
    34 Guilford Road
    Stoneygate
    LE2 2RD Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    34 Guilford Road
    Stoneygate
    LE2 2RD Leicester
    Leicestershire
    British54111520001
    ILES, Mark Willmott
    209 Cutbush Lane
    Townhill Park
    SO18 2GF Southampton
    Hampshire
    Segretario
    209 Cutbush Lane
    Townhill Park
    SO18 2GF Southampton
    Hampshire
    BritishFinancial Director23509110002
    JOHNSON, Ian Edward
    71 Leicester Road
    Oadby
    LE2 4DF Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    71 Leicester Road
    Oadby
    LE2 4DF Leicester
    Leicestershire
    British14396620001
    MATHERS, Stephen
    8 Kingfisher Close
    LE8 9DG Great Glen
    Leicester
    Segretario
    8 Kingfisher Close
    LE8 9DG Great Glen
    Leicester
    British73169370001
    THOMAS, Geoffrey
    19 Main Street
    Houghton On The Hill
    LE7 9GE Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    19 Main Street
    Houghton On The Hill
    LE7 9GE Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector13949310001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DRURY, Peter John
    31 Longmoor Lane
    Sandiacre
    NG10 5LJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    31 Longmoor Lane
    Sandiacre
    NG10 5LJ Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector16238220001
    EAVES, Terence Joseph
    86 Spencer Road
    PO33 3AH Ryde
    Isle Of Wight
    Amministratore
    86 Spencer Road
    PO33 3AH Ryde
    Isle Of Wight
    EnglandBritishAccountant125796830001
    GLEAVE, Linda Margaret
    34 Guilford Road
    Stoneygate
    LE2 2RD Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    34 Guilford Road
    Stoneygate
    LE2 2RD Leicester
    Leicestershire
    BritishNon Executive Dir54111520001
    HILTON, Nicholas Andrew
    Lindisfarne
    7 Longford Park
    TF10 8LW Newport
    Shropshire
    Amministratore
    Lindisfarne
    7 Longford Park
    TF10 8LW Newport
    Shropshire
    EnglandBritishSales Director97484770001
    ILES, Mark Willmott
    209 Cutbush Lane
    Townhill Park
    SO18 2GF Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    209 Cutbush Lane
    Townhill Park
    SO18 2GF Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishFinancial Director23509110002
    JOHNSON, Ian Edward
    71 Leicester Road
    Oadby
    LE2 4DF Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    71 Leicester Road
    Oadby
    LE2 4DF Leicester
    Leicestershire
    BritishFinance Director14396620001
    THOMAS, Geoffrey
    19 Main Street
    Houghton On The Hill
    LE7 9GE Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    19 Main Street
    Houghton On The Hill
    LE7 9GE Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector13949310001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    C.L.C. FIRE PROTECTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 dic 2004
    Consegnato il 21 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 15 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 giu 1995
    Consegnato il 13 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 set 1994
    Consegnato il 09 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • James Edward Savage
    Transazioni
    • 09 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0