JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED

JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02916253
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?

    • (5510) /

    Dove si trova JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GOULDITAR NO.349 LIMITED06 apr 199406 apr 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 apr 2011

    Stato del capitale al 26 apr 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    1 pagineAA

    Bilancio redatto al 28 mar 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    16 pagineMG01

    Dettagli del direttore cambiati per John Francis Jarvis il 05 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen James Hebborn il 05 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Duncan Jeremy Graham Beveridge il 05 nov 2009

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Michael Tunney come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrews come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 29 mar 2008

    11 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    15 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 01 apr 2006

    16 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 26 mar 2005

    16 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BEVERIDGE, Duncan Jeremy Graham
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    British65651540002
    HEBBORN, Stephen James
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish100382260002
    JARVIS, John Francis
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish941890002
    BURNINGHAM, Derek
    58 Brooklands Way
    RH1 2BW Redhill
    Surrey
    Segretario
    58 Brooklands Way
    RH1 2BW Redhill
    Surrey
    British3360080001
    MEENAGHAN, Evelyn Maria
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    Segretario nominato
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    British900001370001
    VINTNER, Barry Sanders
    Maracus Cottage Springwell Lane
    Harefield
    UB9 6PG Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    Maracus Cottage Springwell Lane
    Harefield
    UB9 6PG Uxbridge
    Middlesex
    British8022040001
    ANDREWS, David
    6 Arkendale Road
    IRISH Glengeary
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    6 Arkendale Road
    IRISH Glengeary
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrish91041230001
    LEWIS, Roland Peter
    Driftstone Manor Middle Way
    Kingston Gorse
    BN16 1SB East Preston
    West Sussex
    Amministratore
    Driftstone Manor Middle Way
    Kingston Gorse
    BN16 1SB East Preston
    West Sussex
    United KingdomBritish35930190001
    SEATON, Stuart Neil
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Amministratore delegato nominato
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    United KingdomBritish900001360001
    THOMAS, David Owen
    7 Misbourne House
    Amersham Road
    HP8 4RY Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Misbourne House
    Amersham Road
    HP8 4RY Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    British642560002
    THOMASON, Richard Wooler
    1 Minerva Drive
    WD24 5LD Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Minerva Drive
    WD24 5LD Watford
    Hertfordshire
    British84700430001
    TUNNEY, Michael
    Argyle House
    18 Argyle Road
    IRISH Donnybrook
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Argyle House
    18 Argyle Road
    IRISH Donnybrook
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish114779640002

    JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 15 mar 2010
    Consegnato il 25 mar 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of accession to the guarantee and fixed and floating security document dated 11 december 2003
    Creato il 16 mar 2004
    Consegnato il 19 mar 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and debenture
    Creato il 28 dic 1995
    Consegnato il 08 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the facilities agreement and this guarantee and debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries (Asdefined in the Guarantee and Debenture)
    Transazioni
    • 08 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 lug 1995
    Consegnato il 12 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties(the security trustee) and/or any of the banks(as defined) under the terms of a mortgage debenture dated 25 may 1994 and an overage and share allotment agreement dated 26 may 1994
    Brevi particolari
    All that l/h land k/as land on the east side of ryden avenue,leyland,south ribble,lancashire.t/no.LA585390 and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property belonging to or charged to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rectification and confirmatory charge
    Creato il 04 ago 1994
    Consegnato il 08 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the overage agreement and all other liabilities due from the company to the secured parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Abbey park resort hotel, 77/79 the mount, york, 6 park street, york, north yorks t/no.NYK20021. Felbridge resort hotel, london road, east grinstead, west sussex t/nos. WSX152491 and WSX132597. Wetherby resort hotel leeds road wetherby west yorkshire t/nos.WYK69964 and WYK173127, WYK523521 (formerly YK2088) WYK523522 (formerly YK123315) and WYK523325 (formerly YK1646). Leyland resort hotel, leyland way, leyland, preston, lancashire t/no.LA585390.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 mag 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from goulditar no. 349 limited (now known as jarvis hotels - creating the difference limited) to the chargee and all monies due from the company to the secured parties pursuant to the terms of the overage agreement and all other liabilities of the company to any of the secured parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Secured Parties(As Defined) or Any of Them
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 nov 1992
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    Property k/a wetherby resort hotel leeds road wetherby west yorks. And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 nov 1992
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulitar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    L/H property k/a leyland resort hotel leyland way leyland preston lancashire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 nov 1992
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee all monies due secured on property acquied by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    Property k/a felbridge resort hotel london road east grinstead west sussex. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 nov 1992
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    Property k/a abbey park resort hotel the mount york and 6 park street york. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ott 1992
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    The abbey park hotel the mount york and 6 park street york. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Resort Hotels PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ott 1992
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH 1994
    Brevi particolari
    Property k/a felbridge hotel furze lane east grinstead west sussex. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Resort Hotels PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ott 1992
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    L/H property k/a land east of ryden avenue leyland now k/a the mercury motor inn.
    Persone aventi diritto
    • Resort Hotels PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ott 1992
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    The wetherby grill and the wetherby turnpike motor inn wetherby west yorks.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Resort Hotels PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mag 1988
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    L/H property k/a four acres land to east of ryden avenue leyland south ribble lancashire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mag 1988
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH 1994
    Brevi particolari
    The ladbroke mercury hotel leeds road wetherby west yorks.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mag 1988
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    The abbey park hotel the mount york and 6 park street york.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mag 1988
    Acquisito il 25 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994
    Brevi particolari
    Ye old felbridge hotel and land adjoining furze lane east grinstead west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0