ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED

ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02917485
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Connexions
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ENTERPRISE PROPERTY GROUP LIMITED07 set 200707 set 2007
    ASHTENNE RESIDENTIAL LIMITED10 gen 199610 gen 1996
    ELLINGWELL LIMITED11 apr 199411 apr 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 dic 2022
    Scadenza dei prossimi bilanci il01 dic 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 ago 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 set 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al31 ago 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 gen 2026

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 gen 2025

    17 pagineLIQ03

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Indirizzo della sede legale modificato da Scutches Barn 17 High Street Whittlesford Cambridge CB22 4LT England a Connexions 159 Princes Street Ipswich IP1 1QJ in data 15 gen 2024

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 10 gen 2024

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Cessazione della carica di Robert James Morell Keatley come amministratore in data 20 dic 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dominic Henry Johnstone White come amministratore in data 20 dic 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Charles Micklethwaite come amministratore in data 18 dic 2023

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Peter Robert Stocking come amministratore in data 30 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon John Brown come amministratore in data 30 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Brown come segretario in data 30 set 2023

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2022 al 30 dic 2022

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Katy Sarah Jordan come amministratore in data 19 apr 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Brown come segretario in data 09 mar 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Marilyn Ann Gibb-Rice come segretario in data 09 mar 2023

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Katy Sarah Jordan come amministratore in data 17 ott 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Katy Sarah Jordan come amministratore in data 17 ott 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Katy Sarah Jordan come amministratore in data 17 ott 2022

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 029174850015, creata il 11 ott 2022

    27 pagineMR01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2021

    26 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVISON, Neil John
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Connexions
    Amministratore
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Connexions
    EnglandBritish39292900013
    BROWN, Simon
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Segretario
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    306502990001
    BROWN, Simon John
    Beckbrook Equestrian Centre
    Oakington Road Girton
    CB3 0QH Cambridge
    Segretario
    Beckbrook Equestrian Centre
    Oakington Road Girton
    CB3 0QH Cambridge
    British72693260002
    DAVISON, Neil John
    Church House
    Church Lane
    CB1 6PL Bartlow
    Cambridgeshire
    Segretario
    Church House
    Church Lane
    CB1 6PL Bartlow
    Cambridgeshire
    British39292900002
    GIBB-RICE, Marilyn Ann
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Segretario
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    248650910001
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    BROWN, Simon John
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Amministratore
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    United KingdomBritish72693260002
    JONES, Morgan Lewis
    First Street
    SW3 2LB London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    First Street
    SW3 2LB London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish10146340004
    JORDAN, Katy Sarah
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Amministratore
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish301408910001
    JORDAN, Katy Sarah
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Amministratore
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish209957990001
    KEATLEY, John Rankin Macdonald
    Melbourn Lodge
    SG8 6AL Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Melbourn Lodge
    SG8 6AL Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritish23509620001
    KEATLEY, Robert James Morell
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Amministratore
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    United KingdomBritish94753520002
    MICKLETHWAITE, Christopher Charles
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Amministratore
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish50904570003
    MICKLETHWAITE, Christopher Charles
    Friars Elm Dogkennel Green
    Ranmore
    RH5 6SU Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Friars Elm Dogkennel Green
    Ranmore
    RH5 6SU Dorking
    Surrey
    EnglandBritish50904570002
    MORRISON, Gordon
    Carldane Court Bromley Lane
    SG10 6HU Much Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Carldane Court Bromley Lane
    SG10 6HU Much Hadham
    Hertfordshire
    EnglandBritish1087030003
    STOCKING, Peter Robert
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Amministratore
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish69569450003
    WATSON, Ian Richard
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Amministratore
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish68256540001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    WHITE, Anthony Johnstone
    Workham Farm
    Fifield
    OX7 6HS Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Workham Farm
    Fifield
    OX7 6HS Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish1674470001
    WHITE, Dominic Henry Johnstone
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Amministratore
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish70488140005
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Enterprise Property Group Limited
    High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    27 apr 2018
    High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Neil John Davison
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    06 apr 2016
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 11 ott 2022
    Consegnato il 17 ott 2022
    In corso
    Breve descrizione
    All the chargor's share of and interest now or hereafter subsisting ("the relevant interest") in railway square (chelmsford) LLP including: (a) all distributions, profit shares, interests and bonuses and other income arising out of or accruing in respect of the relevant interest; and (b) all voting and other rights, powers, privileges and other benefits conferred by the relevant interest.. For more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Paragon Development Finance Limited
    Transazioni
    • 17 ott 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 11 apr 2022
    Consegnato il 25 apr 2022
    In corso
    Breve descrizione
    All the chargor’s share of and interest now or hereafter subsisting (“the relevant interest”) in high street (harston) LLP, a limited liability partnership incorporated in england and wales whose registered office is scutches barn, 17 high street, whittlesford, cambs, CB22. 4LT (“the LLP”) including:. (A) all distributions, profit shares, interests and bonuses and other income arising. Out of or accruing in respect of the relevant interest; and. (B) all voting and other rights, powers. For more details of the assets charged please refer to the instrument.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Paragon Development Finance Limited
    Transazioni
    • 25 apr 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of assignment
    Creato il 14 nov 2008
    Consegnato il 21 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower or the company or enterprise to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its partnership interest and its related rights meaning all distributions, all assets and rights derived from, incidental to or offered in exchange for, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 05 nov 2008
    Consegnato il 07 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    £442,000 due or to become due
    Brevi particolari
    Crossroads, water lane, helions bumpstead, halstead, essex.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 2002
    Consegnato il 20 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at lower farm barley herts. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 feb 2002
    Consegnato il 21 feb 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the south of meadow way great offley hitchin. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 21 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 2002
    Consegnato il 02 feb 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The former rectory market place kettering northamptonshire and garden ground t/n-NN219496. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge between the company and enterprise heritage capital limited trading together as the enterprise heritage development partnership ("the mortgagor")(1) the bank (2)
    Creato il 02 nov 2001
    Consegnato il 09 nov 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the legal charge
    Brevi particolari
    All that land adjoining 49 market hill, maldon with all buildings and erections thereon and all fixtures and fittings therein and all services and means of access. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 09 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    A charge over cash between the company and enterprise heritage capital limited together as the enterprise heritage development partnership (the customer) and the chargee
    Creato il 18 ago 2000
    Consegnato il 23 ago 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any account of the customer held by the bank as referred to in facility letter dated 9TH august 2000 addressed from the bank to the customer and any agreement or letter amending supplementing or replacing the same.
    Persone aventi diritto
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 23 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    A legal charge between the company and enterprise heritable capital limited trading together as the enterprise heritage development partnership and the chargee
    Creato il 18 ago 2000
    Consegnato il 23 ago 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 33 and 35 market hill maldon - EX634204 ; f/h property k/a 37 market hill maldon - ex 634203 ; f/h property k/a land on the west side of market hill maldon - EX476477 (see M395 for other properties) and including all buildings and erections thereon and all services and means of access and egress thereto and therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Heritable and General Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 23 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 ago 2000
    Consegnato il 25 ago 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility (as defined)
    Brevi particolari
    Land/blds at 35 king st,leicester; t/no LT152907; the goodwill of business and benefit of licences,as defined, and the benefits thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 25 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 2000
    Consegnato il 23 feb 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility (as defined)
    Brevi particolari
    Land at offley hill service,great offley, hertfordshire t/no.HD214419.by way of assignment the goodwill of the business carried on by the company, the benefit of the licences and the benefits (both as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 23 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge by way of legal mortgage and floating charge over assets
    Creato il 04 gen 2000
    Consegnato il 18 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or courtenay developments limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    39 and 41 silver street t/no;-EX464704 and land adjoining 41 silver street stansted essex and land situate adjacent to and to the rear of 43 silver street stansted together with all buildings fixtures fixed plant and machinery from time to time thereon and by way of first floating charge the assets of the mortgagor both present and future on the property from time to time including all equipment machinery materials and other chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 gen 2000
    Consegnato il 18 gen 2000
    In corso
    Importo garantito
    Overage payments (if any) due from the company and/or courtenay developments limited to the chargee under the terms of an agreement dated 29TH october 1999
    Brevi particolari
    F/H property k/a 39 and 41 silver street and land adjoining 41 silver street stanstead essex t/no;-EX464704 and land situate adjacent to the rear of 43 silver street stanstead. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Harman James Hagon
    Transazioni
    • 18 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 mar 1999
    Consegnato il 25 mar 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at westbury farm great offley hitchin hertfordshire and the goodwill of the business and the benefit of licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 25 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 gen 2024Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Paul Scrivener
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Praticante
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Mark Upton
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Suffolk
    Praticante
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Suffolk

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0