VOYAGE HEALTHCARE LIMITED

VOYAGE HEALTHCARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVOYAGE HEALTHCARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02925614
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Voyage Care Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARAGON HEALTHCARE LIMITED15 apr 200315 apr 2003
    MILBURY COMMUNITY LIMITED22 lug 199422 lug 1994
    BROOMCO (763) LIMITED04 mag 199404 mag 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 31 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share prem acc & cap redemptiob reserve reduced. Cap reduction approved & reserve arising be classed as realised profit. 18/02/2015
    RES13

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Philip Andre Sealey come amministratore in data 09 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Wei Roberts come amministratore in data 09 gen 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 dic 2014

    Stato del capitale al 10 dic 2014

    • Capitale: GBP 1,239,989
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 dic 2013

    Stato del capitale al 09 dic 2013

    • Capitale: GBP 1,239,989
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD* in data 22 nov 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Kevin Wei Roberts come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Mckendrick come amministratore

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    29 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 07 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Winning come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel Moreton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 07 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Segretario
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    British45325360001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Amministratore
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritish45325360001
    WINNING, Andrew
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish73772160002
    BERRY, Philip Thomas
    41 Rosewood Park
    Rosewood Court
    WS6 7HD Cheslyn Hay
    Staffordshire
    Segretario
    41 Rosewood Park
    Rosewood Court
    WS6 7HD Cheslyn Hay
    Staffordshire
    British47529490001
    MORETON, Nigel Keef
    Swan Farm
    Mill Lane
    WS9 9HN Lower Stonnall
    Staffordshire
    Segretario
    Swan Farm
    Mill Lane
    WS9 9HN Lower Stonnall
    Staffordshire
    British57063050002
    SEALEY, Philip Andre
    4 Beoley Hall
    Icknield St Beoley
    B98 9AL Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    4 Beoley Hall
    Icknield St Beoley
    B98 9AL Redditch
    Worcestershire
    British45325360001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BERRY, Philip Thomas
    3 Roman Grange
    B74 3GA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    3 Roman Grange
    B74 3GA Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish47529490002
    BROCK, Julian Richard Christopher
    Haredell
    Martinsend Lane
    HP16 9HR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Haredell
    Martinsend Lane
    HP16 9HR Great Missenden
    Buckinghamshire
    British74294460003
    HARRIS, Nigel Robert
    Cedar Cottage
    Croft Lane, Crondall
    GU10 5QG Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Cedar Cottage
    Croft Lane, Crondall
    GU10 5QG Farnham
    Surrey
    British16250270002
    MCKENDRICK, James Bruce
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish154043480001
    MILESTONE, Neill Frederick, Mr.
    Lysways Hall
    Lysways Lane
    WS15 4QB Longdon Green
    Staffordshire
    Amministratore
    Lysways Hall
    Lysways Lane
    WS15 4QB Longdon Green
    Staffordshire
    EnglandBritish13850080002
    MORETON, Nigel Keef
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritish57063050002
    QUINN, Douglas John
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritish80757840002
    ROBERTS, Kevin Wei
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish72030660002
    SMITH, Andrew Colwyn
    5 Foden Close
    Shenstone
    WS14 0LE Litchfield
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Foden Close
    Shenstone
    WS14 0LE Litchfield
    Staffordshire
    British78023740001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    VOYAGE HEALTHCARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Accession deed
    Creato il 03 apr 2013
    Consegnato il 08 apr 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Fixed and floating security document
    Creato il 04 apr 2006
    Consegnato il 20 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag London Branch as Securuty Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 20 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creato il 02 lug 2004
    Consegnato il 09 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party and any investor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property including: the woodlnds, church lane, acklam, t/no CE8507, belchford, hesledon road, blackhall, t/no DU110208, 336 cowpen road, blyth, t/no ND117576 and for further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag London Branch as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 09 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 set 2001
    Consegnato il 14 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or each other charging company (except for sums owed by such company in it's capacity as a guarantor for the chargor) to the chargee under or pursuant to the senior finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ago 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0