KENTCO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKENTCO LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02925662
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di KENTCO LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova KENTCO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Enterprise House
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KENTCO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LOMBARD STREET PROPERTIES (CANTERBURY) LIMITED27 dic 199627 dic 1996
    LOMBARD STREET PROPERTIES (IPSWICH) LIMITED27 nov 199527 nov 1995
    LOMBARD STREET PROPERTIES (ASHFORD) LIMITED21 lug 199421 lug 1994
    BROOMCO (779) LIMITED04 mag 199404 mag 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di KENTCO LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ago 2010
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mag 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2009

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per KENTCO LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al04 mag 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma18 mag 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KENTCO LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per KENTCO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Cessazione della carica di Stuart Roy Dixon come segretario in data 01 mar 2017

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di David Longworth Birchenall come amministratore in data 06 feb 2017

    2 pagineTM01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 mag 2016

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 nov 2015

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 mag 2015

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 nov 2014

    2 pagine3.6

    Nomina di un curatore o di un gestore

    10 pagineRM01

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    1 pagineRM02

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Christopher Hancock come amministratore

    2 pagineTM01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagine4.72

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Little Westwood Farm Bucks Hill Kings Langley Hertfordshire WD4 9AR United Kingdom* in data 14 lug 2011

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineLQ01

    Nomina di Mr Stuart Roy Dixon come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2011

    Stato del capitale al 05 mag 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Mr Christopher Hancock come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Portland House, Stag Place Bressenden Place London SW1E 5RS United Kingdom* in data 07 ott 2010

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Stuart Dixon come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 24 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH United Kingdom* in data 29 lug 2010

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di KENTCO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DIXON, Stuart Roy
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    Segretario
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    159847750001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Segretario
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    BritishProject Manager27616940001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BIRCH, Sally Ann
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritishSecretary123289480001
    BIRCHENALL, David Longworth
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    Amministratore
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    United KingdomBritishDirector118115050001
    DIXON, Stuart Roy
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House, Stag Place
    United Kingdom
    Amministratore
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House, Stag Place
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant56735900001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    EnglandBritishProject Manager27616940001
    HANCOCK, Christopher
    Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Kynnersley
    England
    Amministratore
    Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Kynnersley
    England
    EnglandBritishSurveyor87069290001
    LAWRENCE, Angela Rosemary
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishPrivate Secretary27616950001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    KENTCO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 30 gen 2008
    Consegnato il 08 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 and f/h property k/a 29 gallowtree gate and 65/69 market place and 1 3 and 5 victoria parade t/no's LT297194 LT13323 LT34591 and LT18286. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transazioni
    • 08 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 304 dic 2013Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 311 lug 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 3
    Deed of assignment
    Creato il 30 gen 2008
    Consegnato il 08 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest under the leases in respect of f/h property k/a 49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 and f/h property k/a 29 gallowtree gate and 65/69 market place and 1 3 and 5 victoria parade t/no's LT297194 LT13323 LT34591 and LT18286. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 106 lug 2011Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 123 nov 2013Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 1
    Second legal charge
    Creato il 30 gen 2008
    Consegnato il 08 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,520,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 65 67 69 market place 29 gallowtree gate and 1 3 and 5 victoria parade leicester t/no's LT18286 LT13323 LT34591 and LT297194.
    Persone aventi diritto
    • Dawnay Day Property Equity Finance Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2008
    • 24 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture (floating charge)
    Creato il 01 mar 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A first floating charge all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold land k/a 28 high street canterbury kent t/n K797851 and freehold landbeing 28 and 29 high street canterbury K. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of yearly rents
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any and all sums due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under the terms of an agreement constituted by a facility letter dated 13 october 1997 the assignment or any other related security document (as defined) or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company's right,title and interest in and to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the existing leases of the land and premises k/a 28/29 high street and 2/5 stour street canterbury kent and any leases of such land and premises or any part thereof subsequently granted within 21 years of the assignment.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over construction contract
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any and all sums due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under the terms of a facility agreement dated 13 october 1997 this deed or any related security document
    Brevi particolari
    "The contract" shall herein mean a construction contract dated 12 december 1997 for the development of 28/29 high street canterbury kent together with any bond issued pursuant thereto.the company's present and future rights,title and interest in and to the contract.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General security assignment
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    "The contract" shall herein mean an agreement for the grant of a lease of the ground and first floor premises at 29 high street canterbury kent.the benefit of the company's right,title and interest in and to the contract.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set off
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The monies now or hereafter to be standing to the credit of any account of the company at the bank.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 29 high street canterbury kent.t/no.K287165.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 12 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The land to be comprised in the title number referred to in the charge including the buildings on the land k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • James Bruce Lee Palmer
    Transazioni
    • 12 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of yearly rents
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 12 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under or pursuant to the terms of an agreement constituted by a facility letter dated 12TH february 1997, the assignment or any other related security document (as defined) or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The companys right title and interest in and to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the existing leases of the land and premises situate and k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 12 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property and the buildings thereon k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent and all those buildings at first floor level and above adjoining the property first referred to but excluding the ground or roadway and those buildings at first floor level including all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 12 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable mortgage
    Creato il 19 feb 1997
    Consegnato il 08 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £125,000.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The contract dated 17/2/97 and any deeds and documents for the purchase of further interests in 28 high street, canterbury, kent and the full benefit thereof and the equitable interest of the company in the property.
    Persone aventi diritto
    • James Bruce Lee Palmer
    Transazioni
    • 08 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    KENTCO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    J Green
    Elliott House 28a Devonshire Street
    W1G 6PS London
    Ricevitore/gestore
    Elliott House 28a Devonshire Street
    W1G 6PS London
    2
    DataTipo
    05 lug 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robin Hamilton Davis
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    Praticante
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    Melvyn Julian Carter
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    Praticante
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    3Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jemma Kathleen Mcandrew
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Ricevitore/gestore
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Richard James Stanley
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Ricevitore/gestore
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0