LHTC LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLHTC LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02930412
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LHTC LTD?

    • Installazione idraulica, termica e di climatizzazione (43220) / Costruzioni
    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova LHTC LTD?

    Indirizzo della sede legale
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LHTC LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LIONHEART TRADING COMPANY LIMITED18 mag 199418 mag 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di LHTC LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LHTC LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LHTC LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagine4.72

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Harworth Park Blyth Road Harworth Doncaster South Yorkshire DN11 8DB* in data 18 lug 2013

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Harworth Secretariat Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Derek Parkin come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Martin Terence Alan Purvis come segretario

    1 pagineAP03

    Dettagli del segretario cambiati per Uk Coal Secretariat Services Limited il 17 apr 2013

    1 pagineCH04

    Cessazione della carica di Simon Taylor come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Gareth Taylor il 12 dic 2012

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di David Brocksom come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    27 pagineMEM/ARTS

    Nomina di Colin Frederick Reed come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Simon Gareth Taylor come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Uk Coal Secretariat Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Jeremy Rhodes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy Rhodes come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    35 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 giu 2012

    Stato del capitale al 29 giu 2012

    • Capitale: GBP 82,100
    SH01

    Nomina di Jeremy Rhodes come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di LHTC LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    1 Bridgewater Place
    Segretario
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    1 Bridgewater Place
    177797450001
    PARKIN, Derek
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    1 Bridgewater Place
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    1 Bridgewater Place
    EnglandBritish177788390001
    REED, Colin Frederick
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish174641750001
    COLE, Richard Andrew
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    British58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    British18761260001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blyth Road Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Harworth Park
    Blyth Road Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    South Yorkshire
    British169993800001
    STREET, Judith Susan
    1 Holland Way
    Newport Pagnell
    MK16 0LL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Holland Way
    Newport Pagnell
    MK16 0LL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British44133930001
    FIRST SECRETARIES LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Segretario nominato
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000780001
    HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8223049
    172322000002
    BOWEN, William John
    23 Heol Y Glyn
    Millbrook Estate
    CF46 5RX Treharris
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    23 Heol Y Glyn
    Millbrook Estate
    CF46 5RX Treharris
    Mid Glamorgan
    Great BritainBritish42096540001
    BROCKSOM, David Graham
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish96416100003
    BUDGE, Richard John
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish27948060002
    COLE, Richard Andrew
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    Amministratore
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    EnglandBritish58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish18761260001
    GRABOWSKI, Peter Alexander
    6 Angus Close
    Kimberley
    NG16 2GX Nottingham
    Amministratore
    6 Angus Close
    Kimberley
    NG16 2GX Nottingham
    EnglandBritish39428690001
    HODGKINSON, Philip
    Accra Mere Road
    Finmere
    MK18 4AW Buckingham
    Oxfordshire
    Amministratore
    Accra Mere Road
    Finmere
    MK18 4AW Buckingham
    Oxfordshire
    British44134010001
    KERRY, Paul
    1 Old London Road High Street
    West Drayton
    DN22 8ED Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    1 Old London Road High Street
    West Drayton
    DN22 8ED Retford
    Nottinghamshire
    British41862730001
    LLOYD, Jonathan Simon
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    Amministratore
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    United KingdomBritish95211330002
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    British99084660001
    MCPHIE, Gordon Allister
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    Amministratore
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    British35904020001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blyth Road Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Harworth Park
    Blyth Road Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish170032420001
    SPINDLER, Garold Ralph
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    Amministratore
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    American101195530002
    STREET, Judith Susan
    1 Holland Way
    Newport Pagnell
    MK16 0LL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Holland Way
    Newport Pagnell
    MK16 0LL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British44133930001
    TAYLOR, Simon Gareth
    The Bent
    Curbar
    S32 3YD Hope Valley
    Robinhill
    England
    England
    Amministratore
    The Bent
    Curbar
    S32 3YD Hope Valley
    Robinhill
    England
    England
    EnglandBritish177290460002
    WESTON, Mark
    Manor Barn
    Main Street Sutton Upon Derwent
    YO41 4BN York
    Amministratore
    Manor Barn
    Main Street Sutton Upon Derwent
    YO41 4BN York
    United KingdomBritish99384510002
    FIRST DIRECTORS LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Amministratore delegato nominato
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000770001

    LHTC LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 26 apr 2012
    Consegnato il 03 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the further company and the existing companies or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Its credit balances.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/06/1999 and
    Creato il 01 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 mar 2004
    Consegnato il 25 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all moneys standing to the credit of any account of the company all benefits due or arising to the company in respect of any and all contracts and policies of insurance taken out by or on behalf of the company or in which the company has an interest all of the companys book trade and other debts the companys goodwill by way of floating charge all of the companys assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 25 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all moneysstanding to the credit of any account, all benefits in respect of the insurances, all of the chargors' book, trade and other debts, all of the chargors' stock and inventory their goodwill and the bene. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Leasing Limited
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 set 2002
    Consegnato il 11 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the "agent") as agent and trustee for the finance parties and the ancillarry bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia
    Transazioni
    • 11 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 giu 1995
    Consegnato il 28 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LHTC LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 lug 2013Inizio della liquidazione
    28 mag 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Bates
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0