KINGSTON PARK LEISURE LIMITED

KINGSTON PARK LEISURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKINGSTON PARK LEISURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02933546
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    40-44 Coombe Road
    KT3 4QF New Malden
    Surrey
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KEWBELL PLC27 mag 199427 mag 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 17 dic 2010

    • Capitale: GBP 0.50
    5 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Memorandum e Statuto

    16 pagineMA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cannons House 40-44 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QF in data 08 giu 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    10 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOLBEN, David George
    49 Sandilands Road
    Fulham
    SW6 2BD London
    Segretario
    49 Sandilands Road
    Fulham
    SW6 2BD London
    British104903050001
    DOYLE, Kevan-Peter
    34 Park Road
    TW1 2PX Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    34 Park Road
    TW1 2PX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish78237230007
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish61663230001
    GARRETT, David Trevarthen
    Heath Lodge
    Heath Drive
    KT20 7QQ Walton On The Hill
    Surrey
    Segretario
    Heath Lodge
    Heath Drive
    KT20 7QQ Walton On The Hill
    Surrey
    British36379600001
    HARRINGTON, Michael
    28 Arlington Avenue
    N1 7AX London
    Segretario nominato
    28 Arlington Avenue
    N1 7AX London
    British900008620001
    OLIVER, Martin Timothy
    Flat 2 Chivelston
    78 Parkside Wimbledon
    SW19 5LH London
    Segretario
    Flat 2 Chivelston
    78 Parkside Wimbledon
    SW19 5LH London
    British50764370001
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Segretario
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    British63240980001
    PRIEST, Jane
    39 Redwood Road
    Kinver
    DY7 6JP Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    39 Redwood Road
    Kinver
    DY7 6JP Stourbridge
    West Midlands
    British47391270002
    SHILCOF, Sarah Alexis
    Roebuck House
    20 The Horsepool
    LE10 2DH Burbage
    Leicestershire
    Segretario
    Roebuck House
    20 The Horsepool
    LE10 2DH Burbage
    Leicestershire
    British40539040001
    STREETS, Matthew Alexander
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Segretario
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    British40530270001
    WISEMAN, David Charles
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Segretario
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    British50807620002
    ANDREW, James Richard Elliott
    Henderson Road
    SW18 3RR London
    15
    Amministratore
    Henderson Road
    SW18 3RR London
    15
    United KingdomBritish139764120001
    APPLEYARD, Barrie Kenneth
    Brentwood
    Kemp Road
    HU14 3LZ Swanland
    North Humberside
    Amministratore
    Brentwood
    Kemp Road
    HU14 3LZ Swanland
    North Humberside
    British41875210001
    FISH, Mark Andrew
    The Orchard
    Court Road
    SL6 8LQ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    The Orchard
    Court Road
    SL6 8LQ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish44086510002
    GOTLA, Christopher James
    60 Elm Grove Road
    Barnes
    SW13 0BT London
    Amministratore
    60 Elm Grove Road
    Barnes
    SW13 0BT London
    British29863490001
    HARRIS, Martin
    Levels House
    BA5 1PF Bleadney
    Somerset
    Amministratore
    Levels House
    BA5 1PF Bleadney
    Somerset
    British75882330001
    JESSOP, Christopher
    Shawfield Street
    SW3 4BD London
    8
    Amministratore
    Shawfield Street
    SW3 4BD London
    8
    United KingdomBritish139864830001
    KETTELL, Stephanie Margaret
    2 Walton House
    GL20 8EX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    2 Walton House
    GL20 8EX Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish63120930001
    LOVATT, Helen Edith
    Saxham Villa
    108 Evesham Road
    GL52 2AN Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Saxham Villa
    108 Evesham Road
    GL52 2AN Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish46017690001
    MISRA, Arnu Kumar
    Hedgerow House 9 Rockwood Road
    Calverley
    LS28 5AB Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Hedgerow House 9 Rockwood Road
    Calverley
    LS28 5AB Leeds
    Yorkshire
    United KingdomBritish227695390001
    MORGAN, Stephen John
    47 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    47 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish23190140003
    OLIVER, Martin Timothy
    25 Cranes Drive
    KT5 8AJ Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    25 Cranes Drive
    KT5 8AJ Surbiton
    Surrey
    British50764370002
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Amministratore
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    EnglandBritish63240980001
    PRIEST, Jane
    39 Redwood Road
    Kinver
    DY7 6JP Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    39 Redwood Road
    Kinver
    DY7 6JP Stourbridge
    West Midlands
    British47391270002
    PSYLLIDES, Milton Nicholas
    Westfield 1 Halloughton Road
    Four Oaks
    B74 2QG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Westfield 1 Halloughton Road
    Four Oaks
    B74 2QG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33137230002
    SHILCOF, Sarah Alexis
    Roebuck House
    20 The Horsepool
    LE10 2DH Burbage
    Leicestershire
    Amministratore
    Roebuck House
    20 The Horsepool
    LE10 2DH Burbage
    Leicestershire
    British40539040001
    STREETS, Matthew Alexander
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Amministratore
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    United KingdomBritish40530270001
    TEGELAARS, Harm Bartholomew
    Farnham House
    Farnham Lane
    TN3 0JT Langton Green
    Kent
    Amministratore
    Farnham House
    Farnham Lane
    TN3 0JT Langton Green
    Kent
    UkDutch16805470001
    WILLIAMS, Christopher
    22 Hardman Road
    KT2 6RH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    22 Hardman Road
    KT2 6RH Kingston Upon Thames
    Surrey
    British102280630001
    WISEMAN, David Charles
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    EnglandBritish50807620002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001

    KINGSTON PARK LEISURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed to a debenture dated 10 may 2001 between inter alia,health club investments limited (the "parent"),health club investments limited and health club acquisitions limited (the "charging companies") and the royal bank of scotland PLC (the "security agent") (the "debenture")
    Creato il 03 lug 2001
    Consegnato il 13 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) to any secured party (as defined) or any other obligor (as defined) in any manner under or in respect of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1996
    Consegnato il 15 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    To secure the performance of the covenants of the company to the chargee contained in a lease of even date
    Brevi particolari
    Land situate close to the junction of st james street with humber bank kingston park in the city of kingston upon hull.
    Persone aventi diritto
    • Kingston upon Hull City Council
    Transazioni
    • 15 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the loan agreement dated 24TH march 1995
    Brevi particolari
    Property close to the junction of st james street with humber bank, kingston park, kingston upon hull. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 giu 1995
    Consegnato il 28 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of agreement for lease
    Creato il 12 apr 1995
    Consegnato il 25 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 24TH march 1995
    Brevi particolari
    (1) by way of assignment the agreement dated 12TH april 1995 (2) by way of assignment all the interest of the company in the land close to the junction of st james street with humber bank, kingston park, kingston upon hull under the lease to be granted by kingston upon hull city council to the ccompany and (3) by way of fixed charge the plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils owned by the company at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 apr 1995
    Consegnato il 24 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0