STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02939508 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | One Great Cumberland Place Marble Arch W1H 7LW London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RAVENSTONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 16 giu 1994 | 16 giu 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 dic 2013 | 9 pagine | 4.68 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario | 1 pagine | 4.40 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Cummings come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee Middleburgh come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NR* in data 11 gen 2013 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Cessazione della carica di Keith Edgar come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Catriona Wadlow come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew Davey il 16 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di un segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Edwards come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Pembertons Secretaries Limited come segretario | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Edwards come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Philip Cummings come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Catriona Ann Wadlow come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Keith Alan Edgar come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED | Segretario | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom |
| 161419710001 | ||||||||||
| DAVEY, Andrew Jonathan | Amministratore | Great Cumberland Place Marble Arch W1H 7LW London One | United Kingdom | British | 136562140001 | |||||||||
| EDWARDS, David Charles | Segretario | Greenbanks Close Milford On Sea SO41 0SQ Lymington 7 Hampshire | British | 123440090026 | ||||||||||
| KRAVETZ, Arthur | Segretario | 36 Alveston Avenue Kenton HA3 8TQ Harrow Middlesex | American | 79883760001 | ||||||||||
| SIMPSON, Fidelity Anne | Segretario | Romshed Farm Underriver TN15 0SD Sevenoaks Kent | British | 11715760001 | ||||||||||
| TAIWO, Bolaji | Segretario | 29 Valeswood Road BR1 4RE Bromley Kent | Nigerian | 114923020001 | ||||||||||
| THOMAS, Lesley Amanda | Segretario | 27 South Cottage Gardens Chorleywood WD3 5EH Rickmansworth Hertfordshire | British | 45975530002 | ||||||||||
| ALPHA SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 2nd Floor 83 Clerkenwell Road EC1R 5AR London | 900004510001 | |||||||||||
| BAGNALL, Paul Gordon | Amministratore | 31 Bennerley Road Battersea SW11 6DR London | British | 81476530001 | ||||||||||
| BANNISTER, Nigel Gordon | Amministratore | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 117929650001 | |||||||||
| CUMMINGS, Philip James | Amministratore | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | England | British | 169752370001 | |||||||||
| EDGAR, Keith Alan | Amministratore | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | England | British | 111105900002 | |||||||||
| EDWARDS, David Charles | Amministratore | Greenbanks Close Milford On Sea SO41 0SQ Lymington 7 Hampshire | United Kingdom | British | 123440090026 | |||||||||
| GASTON, Michael John | Amministratore | 302 Regents Park Road Finchley N3 2JX London Molteno House United Kingdom | England | British | 94566140001 | |||||||||
| MACHIN, Marcus Timothy James | Amministratore | 49 Elmwood Road SE24 9NS London | British | 42403840001 | ||||||||||
| MARSH, Daniel Roff | Amministratore | The Old Rectory High Street Gislingham IP23 8JG Eye Suffolk | United Kingdom | British | 62603960005 | |||||||||
| MIDDLEBURGH, Lee Eamon | Amministratore | Lock View WR11 4PH Evesham 6 Worcs United Kingdom | United Kingdom | British | 103087150001 | |||||||||
| OXENHAM, Mark David | Amministratore | 21 Hampton Gardens CM21 0AN Sawbridgeworth Hertfordshire | England | British | 55563250001 | |||||||||
| PROCTER, William Kenneth | Amministratore | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | England | British | 98678880007 | |||||||||
| RAYDEN, Clive | Amministratore | 79 New Cavendish Street W1W 6XB London | England | British | 2318860008 | |||||||||
| RAYDEN, Paul | Amministratore | 6 Elm Tree Road NW8 9JX London | England | British | 2148080003 | |||||||||
| SIMPSON, Fidelity Anne | Amministratore | Romshed Farm Underriver TN15 0SD Sevenoaks Kent | England | British | 11715760001 | |||||||||
| SIMPSON, Fidelity Anne | Amministratore | Romshed Farm Underriver TN15 0SD Sevenoaks Kent | England | British | 11715760001 | |||||||||
| WADLOW, Catriona Ann | Amministratore | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 114241630002 | |||||||||
| WEBB, David Robert Andrew | Amministratore | Northleigh House Northleigh Lane BH21 2PH Wimborne Dorset | United Kingdom | British | 142155920001 | |||||||||
| WESTON, Martin Wynell Lee | Amministratore | Romshed Farm Underriver TN15 0SD Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 10463320001 | |||||||||
| ESTATES AND MANAGEMENT LIMITED | Amministratore | Euro House 131 - 133 Ballards Lane N3 1GR London | 109852690001 |
STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 20 ott 2006 Consegnato il 01 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge and assignment | Creato il 18 mar 1997 Consegnato il 27 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to an agreement dated 7TH february 1997 and headland weald freehold limited relating to dundeed court 73 wapping high street london E1. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 15 gen 1997 Consegnato il 04 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or headland weald freehold limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
STONEDALE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0